UNISTRUT EUROPE LIMITED

UNISTRUT EUROPE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUNISTRUT EUROPE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01974598
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UNISTRUT EUROPE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra UNISTRUT EUROPE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    3rd Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    West Midlands
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UNISTRUT EUROPE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WENDWALK LIMITED02 ene 198602 ene 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UNISTRUT EUROPE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 sept 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UNISTRUT EUROPE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    16 páginasLIQ13
    A751WSLV

    Domicilio social registrado cambiado de Delta Point Greets Green Road West Bromwich B70 9PL a 3rd Floor Temple Point 1 Temple Row Birmingham West Midlands B2 5LG el 08 jun 2017

    2 páginasAD01
    A6740RCI

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01
    A6740RCQ

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600
    A6740RD6

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 18 may 2017

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20
    S5KA7SIG

    Estado de capital el 22 nov 2016

    • Capital: GBP 0.024
    3 páginasSH19
    A5K9TY6O

    legacy

    1 páginasCAP-SS
    S5KA7SIC

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account cancelled 10/11/2016
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jun 2016

    Estado de capital el 17 jun 2016

    • Capital: GBP 344,808.456
    SH01
    X59C3HMX

    Cuentas completas preparadas hasta el 25 sept 2015

    15 páginasAA
    A55FM235

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jun 2015

    Estado de capital el 17 jun 2015

    • Capital: GBP 344,808.456
    SH01
    X49Q6JAA

    Nombramiento de Daniel Kelly como secretario el 20 abr 2015

    2 páginasAP03
    X48A0QAB

    Cese del nombramiento de Eileen Tierney como secretario el 20 abr 2015

    1 páginasTM02
    X4879UQZ

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 sept 2014

    15 páginasAA
    A445DWS3

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2013

    15 páginasAA
    A3AUOL1M

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 jun 2014

    Estado de capital el 27 jun 2014

    • Capital: GBP 344,808.456
    SH01
    X3AYA3P4

    Cese del nombramiento de Lucy Bentley como director

    1 páginasTM01
    X2YZ5DLV

    Nombramiento de Paul Graham Merrick como director

    2 páginasAP01
    X2MZFL9F

    Nombramiento de Carl Edward Jones como director

    2 páginasAP01
    X2CUFFPU

    Cese del nombramiento de Audie Homer como director

    1 páginasTM01
    X2CUFE5E

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 sept 2012

    15 páginasAA
    A2BIHI4X

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01
    X2A92C4J

    Cese del nombramiento de Gary Uren como director

    1 páginasTM01
    X26DGJY0

    ¿Quiénes son los directivos de UNISTRUT EUROPE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KELLY, Daniel
    16100 S. Lathrop Avenue
    Harvey
    Atkore International, Inc.
    Il 60426
    United States
    Secretario
    16100 S. Lathrop Avenue
    Harvey
    Atkore International, Inc.
    Il 60426
    United States
    198019240001
    JONES, Carl Edward, Mr.
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    3rd Floor Temple Point
    West Midlands
    Director
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    3rd Floor Temple Point
    West Midlands
    United KingdomBritishGeneral Manager179922340001
    MALLAK, James Adam
    S. Lathrop Avenue
    60426 Harvey
    16100
    Illinois
    United States
    Director
    S. Lathrop Avenue
    60426 Harvey
    16100
    Illinois
    United States
    United StatesAmericanGeneral Management176030640001
    MERRICK, Paul Graham
    Delta Point
    Greets Green Road
    B70 9PL West Bromwich
    Unistrut Limited
    United Kingdom
    Director
    Delta Point
    Greets Green Road
    B70 9PL West Bromwich
    Unistrut Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant183560840001
    WILLIAMSON, John Patrick
    S. Lathrop Avenue
    60426 Harvey
    16100
    Illinois
    United States
    Director
    S. Lathrop Avenue
    60426 Harvey
    16100
    Illinois
    United States
    United StatesAmericanExecutive (Ceo & President, Atkore International)160896890001
    BOLDISON, Alison
    Preston View
    Swillington
    LS26 8UG Leeds
    28
    West Yorkshire
    Secretario
    Preston View
    Swillington
    LS26 8UG Leeds
    28
    West Yorkshire
    Other129655150001
    CATT, Nicholas William
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    Secretario
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    BritishFinance Director128624750001
    DAVIS, John Stuart
    South Lathrop Ave
    Harvey
    16100
    Il 60426
    Usa
    Secretario
    South Lathrop Ave
    Harvey
    16100
    Il 60426
    Usa
    157299020001
    HALL, Patricia Margaret
    Cheltenham House
    Main Street
    MK18 2HT Adstock
    Buckinghamshire
    Secretario
    Cheltenham House
    Main Street
    MK18 2HT Adstock
    Buckinghamshire
    British38724320003
    LATHAM, Graham Charles Mason
    27 Whitewells Gardens
    Scholes
    HD9 1TZ Holmfirth
    Secretario
    27 Whitewells Gardens
    Scholes
    HD9 1TZ Holmfirth
    BritishAccountant81181550001
    MINTON, Stephen John
    Ridgeway Road
    DY8 5UE Stourbridge
    42
    West Midlands
    Secretario
    Ridgeway Road
    DY8 5UE Stourbridge
    42
    West Midlands
    British132252620001
    ROUS, Simon Nicholas
    8 Brackenwood
    Orton Wistow
    PE2 6YP Peterborough
    Cambridgeshire
    Secretario
    8 Brackenwood
    Orton Wistow
    PE2 6YP Peterborough
    Cambridgeshire
    British25468180001
    SHAW, Neil John
    6 Haresmoor Drive
    NN12 6HB Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    6 Haresmoor Drive
    NN12 6HB Towcester
    Northamptonshire
    BritishAccountant127485980001
    TIERNEY, Eileen
    S. Lathrop Avenue
    Harvey
    16100
    Illinois 60426
    Usa
    Secretario
    S. Lathrop Avenue
    Harvey
    16100
    Illinois 60426
    Usa
    159265380001
    WHITE, Peter
    20 Huntsmead
    NN3 5HT Northampton
    Northamptonshire
    Secretario
    20 Huntsmead
    NN3 5HT Northampton
    Northamptonshire
    British57497590001
    WILSON, Paul Justin
    10 Stewart Court
    MK43 9PH Wootton
    Bedfordshire
    Secretario
    10 Stewart Court
    MK43 9PH Wootton
    Bedfordshire
    British78628190002
    BENTLEY, Lucy Alexandra
    Arley Close
    Alsager
    ST7 2XA Stoke-On-Trent
    16
    Staffordshire
    Director
    Arley Close
    Alsager
    ST7 2XA Stoke-On-Trent
    16
    Staffordshire
    United KingdomBritishAccountant130551180001
    BROWNING, Gordon Robert
    Linbeck
    Linton
    BD23 5HQ Skipton
    North Yorkshire
    Director
    Linbeck
    Linton
    BD23 5HQ Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritishManager142600170001
    CADY, Edward Carver
    5245 Milroy Lane
    Brighton
    Michigan 48116
    United States Of America
    Director
    5245 Milroy Lane
    Brighton
    Michigan 48116
    United States Of America
    Us CitizenDirector Unistrut International Corporation12890970001
    CAMPBELL, Stephen John
    27 Hazel Drive
    Hollywood Wythall
    B47 5RJ Birmingham
    West Midlands
    Director
    27 Hazel Drive
    Hollywood Wythall
    B47 5RJ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishManaging Director112964160001
    CATT, Nicholas William
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    Director
    Farquhar Street
    SG14 3BP Hertford
    Little Eaves 6
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director128624750001
    CONNORS, Nelda Janine
    N. Pine Grove Avenue
    Chicago
    2741
    Il 60614
    Usa
    Director
    N. Pine Grove Avenue
    Chicago
    2741
    Il 60614
    Usa
    UsaUsaPresident, Tyco Electrical & Metal Products Divisi176652870001
    FAZAKERLEY, Malcolm
    Plassey
    Kinnerley
    SY10 8EE Oswestry
    Bank House
    Shropshire
    Director
    Plassey
    Kinnerley
    SY10 8EE Oswestry
    Bank House
    Shropshire
    BritishAccountant138383980001
    FRICKER, Siegfried
    Wacholderweg 27
    7258 Heimsheim
    Germany
    Director
    Wacholderweg 27
    7258 Heimsheim
    Germany
    GermanConsultant12890980001
    GRIGG, Roger
    Rivermead House Eccleshall Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Director
    Rivermead House Eccleshall Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    BritishFinance Director48129340001
    GUTIN, Irving
    1 Tyco Park
    Exeter
    New Hampshire
    03833
    Usa
    Director
    1 Tyco Park
    Exeter
    New Hampshire
    03833
    Usa
    AmericanCompany Executive49049420001
    HOMER, Audie Samuel
    Bells Lane
    Wordsley
    DY8 5DQ Stourbridge
    62
    West Midlands
    Director
    Bells Lane
    Wordsley
    DY8 5DQ Stourbridge
    62
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Manager138381700001
    HUMPHREYS, Charles Edward
    Santa Lane
    11 60480 Willow Springs
    162
    Usa
    Director
    Santa Lane
    11 60480 Willow Springs
    162
    Usa
    AmericanManagement131080160001
    KEMP, Axel
    Madrid
    C/ Pardo Bazan 14
    Spain
    Director
    Madrid
    C/ Pardo Bazan 14
    Spain
    GermanBusinessman137508010001
    KINSEY, Thomas Richard Moseley
    6 Sutton Lodge
    B91 1NB Solihull
    West Midlands
    Director
    6 Sutton Lodge
    B91 1NB Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector48481570001
    MALFESE, Constantine John
    8225 Pawnee Trail
    Pinckney
    Michigan 48169
    United States Of America
    Director
    8225 Pawnee Trail
    Pinckney
    Michigan 48169
    United States Of America
    Us CitizenPresident Unistrut International Corporation12890960001
    MEYER, Philippe Claude Dominique
    1 Place Du Chateau
    54115 Vandeleville
    France
    Director
    1 Place Du Chateau
    54115 Vandeleville
    France
    FrenchCompany Executive49598760001
    MINTON, Stephen John
    Ridgeway Road
    DY8 5UE Stourbridge
    42
    West Midlands
    Director
    Ridgeway Road
    DY8 5UE Stourbridge
    42
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant132252620001
    NICHOLAS, David Charles
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Director
    Lillingstone House
    84 Knowle Wood Road Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishManaging Director96403410001
    RATHMILL, Keith
    7 Selkirk Drive
    CW4 7LJ Holmes Chapel
    Cheshire
    Director
    7 Selkirk Drive
    CW4 7LJ Holmes Chapel
    Cheshire
    BritishManaging Director60555300002

    ¿Tiene UNISTRUT EUROPE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee and debenture
    Creado el 25 feb 1994
    Entregado el 17 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 03 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment for security purposes
    Creado el 02 ene 1990
    Entregado el 22 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreement dated 24TH july 1989
    Breve descripción
    All existing and future claims including secondary rights to which the company may be entitled pursuant to a loan agreement dated 28 july 1989 between the company and unistrut gmbh & co kg all the following securities guaranteeing the assigned claims were transferred by way of charge to the bank, together with the assigned claims:- the benefit of a land charge of dm 11,300,000 registered in the register of titles of wiernsheim local court district of maulbronn volume no. 6646 dept 111, no 1 and 2 against unistrut gmbh & co. Kg (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 22 ene 1990Registro de una carga
    • 03 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of patents
    Creado el 02 ene 1990
    Entregado el 22 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All the patents and rights out of patent applications listed in a schedule to form 395 (see form 395 & schedule for full details).
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 22 ene 1990Registro de una carga
    • 03 ene 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 03 feb 1986
    Entregado el 24 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 3/2/86.
    Breve descripción
    (Including trade fixtures & fittings). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston
    Transacciones
    • 24 feb 1986Registro de una carga

    ¿Tiene UNISTRUT EUROPE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 may 2017Inicio de la liquidación
    15 ago 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Malone
    8th Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Profesional
    8th Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Gareth Prince
    8th Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Profesional
    8th Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0