LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED

LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01974805
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NATWEST LEASING INDUSTRIES LIMITED13 jul 199013 jul 1990
    LOMBARD LEASING INDUSTRIES LIMITED22 abr 198622 abr 1986
    HARPBUY LIMITED03 ene 198603 ene 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 páginasAD02

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Domicilio social registrado cambiado de 25 Gresham Street London EC2V 7HN a 1 More London Place London SE1 2AF el 23 ene 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 dic 2016

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Colin Graham Dowsett como director el 16 nov 2016

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2015 au 30 jun 2016

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 jun 2016

    Estado de capital el 06 jun 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Kevin Charles Harris como director el 30 sept 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Robert Turner como director el 23 sept 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jun 2015

    Estado de capital el 02 jun 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Kevin Charles Harris el 06 mar 2015

    2 páginasCH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    1 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jun 2014

    Estado de capital el 04 jun 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Sharon Slattery como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Lloyds Secretaries Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Robin Isaacs como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Colin Graham Dowsett como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02791894
    73512200003
    TURNER, John Robert
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    EnglandBritish76185650001
    BLACK, Nicola Suzanne
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretario
    Springfield
    24 Drovers Way
    CM23 4GF Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British52160130002
    BUTLIN, Rachel Elizabeth
    44 Stopher House
    Webber Street
    SE1 0SE London
    Secretario
    44 Stopher House
    Webber Street
    SE1 0SE London
    British5966810002
    LEWIS, Sally Elizabeth
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    Secretario
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    British4807180001
    SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs.
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Secretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Irish45487120004
    BAILEY, Richard James
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Director
    17 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    British37824840001
    BARTON-SMITH, Colim
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Barn Mead Keepers Lane
    Hyde Heath
    HP6 5RJ Amersham
    Buckinghamshire
    British23187320002
    BASING, Anthony Mark
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    36 Selwyn Crescent
    AL10 9NN Hatfield
    Hertfordshire
    British99221710001
    BULL, Richard Piers Ashworth
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Otter 16 Brindley Quays
    Braunston
    NN11 7AN Daventry
    Northamptonshire
    British34371520003
    CARPENTER, Paul
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    Director
    Broadoak 4 Overhill Road
    CR8 2JD Purley
    Surrey
    United KingdomBritish53756030002
    COOKE, Timothy John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Director
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish120834610001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Director
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    United KingdomBritish46297770002
    CUMMING, Andrew John
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    Director
    305 Mountjoy House
    Barbican
    EC2Y 8BP London
    United KingdomBritish46297770002
    DAVIES, John Anthony
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Westmead Stables
    Weedon
    HP22 4NN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British32423210001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritish96202910001
    DENT, Nicholas Michael
    78a Wendover Road
    TW18 3DD Egham
    Surrey
    Director
    78a Wendover Road
    TW18 3DD Egham
    Surrey
    British43922780001
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish152332230001
    FOAD, Allan Robert
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    Director
    19 Dukes Orchard
    DA5 2DU Bexley
    Kent
    British40761160001
    GRANT, Mark Andrew
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    Director
    Silverdale Avenue
    KT12 1EL Walton-On-Thames
    177
    Surrey
    United KingdomBritish236442470001
    GREEN, Michael Jonathan
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    Director
    109 Hampstead Way
    NW11 7LR London
    EnglandBritish141461000001
    HARRIS, Kevin Charles
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    Director
    London Wall
    EC2Y 5AJ London
    125
    United Kingdom
    United KingdomBritish170091040001
    HARRISON, David Henry Arnold
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    Director
    Woodcote Lodge
    West Horsley
    KT24 6ET Leatherhead
    Surrey
    UkBritish8949580001
    HENDERSON CLELAND, Hugh John
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    Director
    6 Steep Hill
    Streatham
    SW16 1UL London
    British57536880001
    HERBERT, Jon Mark
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish203539400001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Director
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    HILLIARD, Adrian Richard
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    Director
    50 Old Shoreham Road
    Portslade
    BN41 1SN Brighton
    Sussex
    British49021840001
    HING, Allen Peter
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    Director
    59 Woodbastwick Road
    Sydenham
    SE26 5LG London
    British11403910001
    ISAACS, Robin Alexander
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    Director
    Gresham Street
    EC2V 7AE London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish115548350001
    JOSEPH, Michael William
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    Director
    The Hermitage
    St Leonards
    HP23 6NW Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish44954410002
    KEIGHLEY, Peter Thomas
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    Director
    36 Longfield Lane
    Cheshunt
    EN7 6AD Waltham Cross
    Hertfordshire
    British43234170001
    KING, Roger Steuart
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    Director
    9 Kingfisher House
    No 6 Melbury Road
    W14 8LN London
    United States Citizen79713690002
    MILES, Peter Bernard
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    Director
    Brentwood House
    Winchester Road
    GU32 1JS West Meon
    Hampshire
    British41327480001
    PASHLEY, Robert Lawrence
    Apartment 29d
    145 East 48th Street
    FOREIGN New York Usa
    Ny 10017
    Director
    Apartment 29d
    145 East 48th Street
    FOREIGN New York Usa
    Ny 10017
    British34481270003
    PELLY, Richard Fowler
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    Director
    126 Dora Road
    Wimbledon
    SW19 7HJ London
    EnglandBritish99868440002

    ¿Tiene LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Amended and restated intercreditor agreement
    Creado el 19 dic 1997
    Entregado el 31 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights
    Breve descripción
    If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited
    Transacciones
    • 31 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 21 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this chattel mortgage and under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the lessor direct agreement (as defined)
    Breve descripción
    First fixed charge all rights title and interest in and to the english equipment (other than any software licences); the english sale proceeds and all moneys (including interest) standing to the credit of the sale proceeds account and the debt(s) represented thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Chase Manhattan Bank, N.A.as Agent and Trustee for the Senior Creditors (As Defined)
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Intercreditor agreement (the "intercreditor agreement")
    Creado el 21 dic 1995
    Entregado el 05 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    (A) the senior debt, (b) the lease debt and (c) the subordinated debt (all as defined in the intercreditor agreement)
    Breve descripción
    If at any time prior to the senior discharge date the lessor receives a payment or distribution in cash or in kind of or on account of any lease debt such debt shall be held in trust for security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Chase Manhattan Bank N.A.as Security Agent and Trustee for the Senior Creditors and the Lessor
    Transacciones
    • 05 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 26 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LLOYDS (NIMROD) LEASING INDUSTRIES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 dic 2016Inicio de la liquidación
    13 feb 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0