EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED

EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01979747
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Handover Centre Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EMBASSY DEVELOPMENTS LIMITED10 jul 198610 jul 1986
    EMBASSY DEVELOPMENTS (EDGBASTON) LIMITED13 jun 198613 jun 1986
    TASKPLACE LIMITED20 ene 198620 ene 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2021 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Consolidación de acciones el 03 sept 2021

    4 páginasSH02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital el 06 sept 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Consolidation 03/09/2021
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 02 sept 2021

    • Capital: GBP 50,002
    3 páginasSH01

    Retiro de la solicitud de exclusión de la empresa

    1 páginasDS02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Paul Clement Scott como director el 07 jun 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Clement Scott como secretario el 07 jun 2021

    1 páginasTM02

    Cancelación total de la carga 45

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020

    9 páginasAA

    Cambio de datos del director Mrs Alexandria Varley el 15 nov 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Paul Clement Scott el 15 nov 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Paul Clement Scott el 15 nov 2019

    1 páginasCH03

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slough SL3 6AD a The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL el 22 oct 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2019

    9 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VARLEY, Alexandria
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Director
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritishAccountant114926980004
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretario
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British106610560001
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Secretario
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    British22634560001
    WOODSIDE SECRETARIES LIMITED
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    Secretario corporativo
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    8879140001
    BENDER, Stephen David
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    Director
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant80314720001
    BRIDGES, Stuart John
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    Director
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritishCorporate Financier42176090002
    CLEVELEY, Michael Richard
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Great BritainBritishCompany Director116430680001
    HOLBECHE, Roger Malcolm
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    Director
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director16353130007
    KINGSHOTT, Michael James
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    Director
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishDirector83713020001
    NUTTALL, Peter Donald
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    Director
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant29476820001
    PASCAN, Paul Michael
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    BritishAccountant52572380001
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Director
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant106610560001
    RUSSELL, Barry Charles
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    Director
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    BritishProperty Manager38094780002
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Director
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritishCompany Secretary22634560001
    TICEHURST, Jonathon Mark
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    Director
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    BritishProperty Manager87622850001
    TORLAGE, Kevin Edgar
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Director
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    United KingdomSouth AfricanAccountant88938440001
    TRUEMAN, Peter Roy
    52 Dodford Road
    Bournheath
    B61 9JR Bromsgrove
    Worcestershire
    Director
    52 Dodford Road
    Bournheath
    B61 9JR Bromsgrove
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director31798580001
    WINDER, Simon Paul
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    Director
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    BritishAccountant75937140001
    WINDUSS, David Alexander
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    Director
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    EnglandBritishAccountant64556700001
    YERBURY, John William Richard
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    Director
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    BritishDirector50339880001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bidvest Outsourced Services Limited
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    01 jul 2016
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUk Companies Act
    Lugar de registroCompanies House Cardiff
    Número de registro1997606
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene EMBASSY PROPERTY GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Third party legal charge
    Creado el 29 sept 2003
    Entregado el 11 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from astindale properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land k/a the timber yard, cranbrook road, gills green, cranbrook t/no K422631. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 may 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 22 oct 2001
    Entregado el 25 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a the timber yard cranbrook road gills green cranbrook kent t/n K422631. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 25 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 29 mar 2001
    Entregado el 11 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings lying to the north of station road goudhurst kent K703321. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 13 mar 1997
    Entregado el 20 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 26 may 1995
    Entregado el 15 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Agreements for lease in respect of phase iii, kingsway retails park, rowditch derby. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 15 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of further charge
    Creado el 23 nov 1993
    Entregado el 25 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined in the further charge
    Breve descripción
    L/H property situate on the south-east side of harbourne road and on the north west side of calthorpe road birmingham west midlands.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 25 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 01 sept 1993
    Entregado el 15 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Site of former electricity sub-station at kingsway retail park derby.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 15 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 18 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 14 sept 1992
    Entregado el 17 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 08/07/91
    Breve descripción
    The monies from time to time standing to the credit of account number 9837 with hill samuel bank limited opened by embassy developments limited.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 17 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of further charge
    Creado el 11 sept 1992
    Entregado el 16 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined
    Breve descripción
    Leasehold property situate on the south east side of harborne road and the northwest side of calthorpe road birmingham west midlands.
    Personas con derecho
    • Singer & Friedlander Limited
    Transacciones
    • 16 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 20 ago 1992
    Entregado el 04 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All rental income due to the company in respect of the provision of car parking spaces or advertising hoarding spaces at any of the following property:- 23 great prescot street, stepney t/no. 165026 and 62/63 royal mint street and 4-10 dock street t/no. EGL221445.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transacciones
    • 04 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 mar 1992
    Entregado el 08 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 08 jul 1991
    Entregado el 11 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 23/03/89
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to two agreements dated 8TH july 1991 relating to the sale of two parts of land charged to the mortgagee and an agreement for lease dated 26/07/90. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 1991Registro de una carga
    • 18 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creado el 08 jul 1991
    Entregado el 09 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Phase 1 kingsway retail park rowditch derby with all buildings and fixtures from time to time thereon.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 09 jul 1991Registro de una carga
    • 05 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 abr 1991
    Entregado el 17 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property k/as land on the south-east side of harborne road and on the north-west side of calthorpe road birmingham title no WM406016.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 1991Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of further charge and variation
    Creado el 11 abr 1991
    Entregado el 15 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Leasehold situate on the south east side of harborne road and the north west side of calthorpe road, birmingham, west midlands title no WM406016 agreements dated 13/1/8M and 31/3/8. and all profit and rents of the above property.
    Personas con derecho
    • Singer & Freidlander Limited
    Transacciones
    • 15 abr 1991Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 02 nov 1990
    Entregado el 06 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a or being helena house ormskirk st., St helens merseyside, with all buildings & fixtures assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 1990Registro de una carga
    • 25 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 02 nov 1990
    Entregado el 06 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a or being 13/15 warwick new road leamington spa, warwickshire t/no. Wk 324538 assignment of the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 06 nov 1990Registro de una carga
    • 25 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 oct 1990
    Entregado el 11 oct 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold land at buildwin street st helens merseyside t/no. Ms 289876.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 11 oct 1990Registro de una carga
    • 17 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 27 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    23 prescot street london t/no. Ln 165026.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 27 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    62/63 royal mint st., London E1 t/no. LN144343.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 27 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    10 dock street london E1 t/no. Ln 101125.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 27 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    8 dock street london E1 t/no. Ln 93398.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 sept 1990
    Entregado el 27 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    4-6 dock street london E1 t/no. Ln 101926.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Leasehold land & buildings k/a prospect ii phoenix way swansea enterprise zone swansea, west glam with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Ucb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold land & buildings k/a castle lodge castle square ludlow, shrops with all buildings & fixtures the goodwill of the business and the full benefit of all present & future licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Ucb Bank PLC
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0