WN IT MANAGED SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WN IT MANAGED SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01983540 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
- Otras actividades de telecomunicaciones (61900) / Información y comunicación
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley B90 8BG Solihull England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DAISY IT MANAGED SERVICES LIMITED | 01 dic 2015 | 01 dic 2015 |
| PHOENIX IT MANAGED SERVICES LIMITED | 12 sept 2013 | 12 sept 2013 |
| SERVO LIMITED | 26 sept 2008 | 26 sept 2008 |
| ICM MANAGED AVAILABILITY SERVICES LIMITED | 01 ago 2007 | 01 ago 2007 |
| ICM MANAGED AVAILABILITY SERVICES PLC | 31 ago 2006 | 31 ago 2006 |
| ICM SUPPORT SERVICES PLC | 24 ene 2000 | 24 ene 2000 |
| TEAM COMPUTER SERVICES PLC | 30 nov 1995 | 30 nov 1995 |
| ICM COMPUTER GROUP PLC | 26 jun 1991 | 26 jun 1991 |
| INDEPENDENT COMPUTER MAINTENANCE LIMITED | 24 mar 1986 | 24 mar 1986 |
| SIMCO NO. 111 LIMITED | 29 ene 1986 | 29 ene 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 06 oct 2024 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 26 mar 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Dwf Company Secretarial Services Limited 1 Scott Place 2 Hardman Street Manchester M3 3AA United Kingdom a One Central Boulevard Central Boulevard Shirley Solihull B90 8BG | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley Solihull B90 8BG | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 13 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed daisy it managed services LIMITED\certificate issued on 02/08/24 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Kristian Brian Lee como director el 11 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Philip Thompson como director el 11 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lyndsey Jayne Charlton como director el 11 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Philip Howard Grannum como director el 11 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Venetia Lois Cooper como director el 11 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Lindred House, 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR a Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley Solihull B90 8BG el 30 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 019835400013 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 019835400014 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Philip Thompson como director el 31 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul John Worthington como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER, Venetia Lois | Director | Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley B90 8BG Solihull Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard England | England | British | 189111310001 | |||||
| GRANNUM, Philip Howard | Director | Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley B90 8BG Solihull Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard England | England | British | 325614230001 | |||||
| FAIREY, Michael Craig | Secretario | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | British | 113317640001 | ||||||
| MARTIN, William Thomas | Secretario | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Secretario | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | 199438750001 | |||||||
| STOKES, Reeta | Secretario | Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Technology House Northamptonshire England | 173999660001 | |||||||
| TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Secretario | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northampton England | 179711670001 | |||||||
| WAINWRIGHT, Stephen | Secretario | Cedar Lodge Molly Hurst Lane Wooley WF4 2JX Wakefield West Yorkshire | British | 13393650001 | ||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Director | c/o Phoenix It Group Plc Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Technology House Northamptonshire England | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||
| BERTRAM, Peter Michael | Director | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | 52852920002 | |||||
| BOITELLE, Gerard Bernard Emilien | Director | 145 Scotchman Lane Morley LS27 0NU Leeds West Yorkshire | British | 17176280001 | ||||||
| CHARLTON, Lyndsey Jayne | Director | Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley B90 8BG Solihull Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard England | United Kingdom | British | 280737130001 | |||||
| CLUTTON, Steven | Director | Oakwell Way Oakwell Business Park WF17 9LU Birstall Phoenix House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 158451560001 | |||||
| COURTLEY, David John | Director | Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Technology House Northants United Kingdom | England | British | 141213480001 | |||||
| CRITCHLEY, Eric | Director | 24 Springfield Thringstone LE67 8LT Coalville Leicestershire | British | 8184260001 | ||||||
| FAIREY, Michael Craig | Director | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | United Kingdom | British | 113317640001 | |||||
| GRANELLI, Anthony | Director | 37 Woodthorpe Park Drive Sandal WF2 6SU Wakefield West Yorkshire | England | British | 8185550001 | |||||
| GRIGGS, Gavin Peter | Director | Lindred Road Business Park, BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire | England | British | 154536120001 | |||||
| JONES, Andrew | Director | Shaw Lane Beckwithshaw HG3 1RA Harrogate Beckfield Grange England England | United Kingdom | British | 119744050001 | |||||
| KAY, Matthew Martin | Director | Laurel Bank Luddenden Foot HX2 6PS Halifax 2 West Yorkshire | England | British | 137007340001 | |||||
| LEE, Kristian Brian | Director | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House United Kingdom | England | British | 305579540001 | |||||
| MARKE, Nathan Richard | Director | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| MCGLENNON, David Lewis | Director | Lindred Road Business Park, BB9 5SR Nelson Daisy House, Lancashire | United Kingdom | British | 181536600001 | |||||
| MILNE, Neil Morrison | Director | 49 College Cross N1 1PT London | British | 6057610002 | ||||||
| MULLER, Neil Keith | Director | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | England | British | 252490400001 | |||||
| OLIVER, Stefni Watson | Director | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House, | England | British | 244258880001 | |||||
| RILEY, Matthew Robinson | Director | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 178585250001 | |||||
| ROBERTS, Barry Arthur | Director | 7 Tudor Lawns Carr Gate WF2 0UU Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 8184250002 | |||||
| ROBINSON, Nicholas John | Director | Ferry Nab Lane SL7 2EZ Medmanham Ferry Nab England United Kingdom | United Kingdom | British | 54873290006 | |||||
| ROBINSON, Nicholas | Director | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | 54873290005 | ||||||
| SIMPSON, David Alan | Director | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | 80817560001 | |||||
| SMITH, Stephen Alan | Director | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | 161471940001 | |||||
| STAFFORD, Jeremy John | Director | The Old Rectory Lower Weald, Calverton MK19 6EE Milton Keynes Bucks | England | British | 116431970001 | |||||
| STRAND, Graham John | Director | 24 Riding Hill CR2 9LN South Croydon Surrey | British | 104758530001 | ||||||
| THOMPSON, Neil Philip | Director | Central Boulevard, Blythe Valley Park Shirley B90 8BG Solihull Wavenet Group, Second Floor One Central Boulevard England | United Kingdom | British | 306742370001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WN IT MANAGED SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy Computer Group Limited | 06 abr 2016 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0