WINNALL DOWN FARM THREE LTD

WINNALL DOWN FARM THREE LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWINNALL DOWN FARM THREE LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01984079
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Dirección de la sede social
    Manor Farm
    Bighton
    SO24 9RD Alresford
    Hampshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BOX-IT IMAGE MANAGEMENT LIMITED03 oct 201103 oct 2011
    F-M IMAGE MANAGEMENT LIMITED29 nov 199629 nov 1996
    FICHEMASTER LIMITED06 oct 198706 oct 1987
    FICHE-MASTER LIMITED30 ene 198630 ene 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 019840790012

    1 páginasMR04

    Domicilio social registrado cambiado de Box-It Winnall Down Farm Alresford Road Winchester Hampshire SO21 1FP a Manor Farm Bighton Alresford Hampshire SO24 9rd el 18 jun 2018

    1 páginasAD01

    Notification de John Simon Bruce Mccowen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 feb 2018

    2 páginasPSC01

    Cessation de Box-It Outsourcing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 feb 2018

    1 páginasPSC07

    Cese del nombramiento de David Anthony Mccormick como director el 06 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Patrick Ellis como director el 06 mar 2018

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name07 feb 2018

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 06 feb 2018

    RES15

    Cambio de datos del director Mr Simon Patrick Ellis el 28 dic 2017

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr David Anthony Mccormick como director el 11 ene 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Mark Penfound como director el 30 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2016

    Estado de capital el 12 ene 2016

    • Capital: GBP 1,334,517.5
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    11 páginasAA

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCCOWEN, John Simon Bruce
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Director
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector43693610001
    ELLIS, Kathleen Mary
    Pentyre 11 Winchester Road
    SP10 2EG Andover
    Hampshire
    Secretario
    Pentyre 11 Winchester Road
    SP10 2EG Andover
    Hampshire
    British62527740001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Secretario corporativo
    Staples Court
    11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    39754020001
    ROXBURGHE HOUSE REGISTRARS LIMITED
    2nd Floor Roxburghe House
    273-287 Regent Street
    W1B 2AD London
    Secretario corporativo
    2nd Floor Roxburghe House
    273-287 Regent Street
    W1B 2AD London
    49253240002
    SOUTHERN CORPORATE SERVICES LIMITED
    Fleming Court
    Leigh Road
    SO50 9PD Eastleigh
    Southampton
    Secretario corporativo
    Fleming Court
    Leigh Road
    SO50 9PD Eastleigh
    Southampton
    89479840001
    BRANDON, John Robert
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    Director
    28 Marsh Lane
    Mill Hill
    NW7 4QP London
    United KingdomBritishBusinessman99584240001
    CUMBERLAND, John Peter
    1 Warlingdean
    33 New Road
    KT10 9PG Esher
    Surrey
    Director
    1 Warlingdean
    33 New Road
    KT10 9PG Esher
    Surrey
    United KingdomBritishChairman45642470003
    ELLIS, Simon Patrick
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Director
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    EnglandBritishDirector116198200003
    ELLIS, Simon Patrick
    47 Winchester Street
    Overton
    GR25 3HT Basingstoke
    Hampshire
    Director
    47 Winchester Street
    Overton
    GR25 3HT Basingstoke
    Hampshire
    BritishComputer Consultant8370890007
    HOLMES, Marcus Forbes Hamilton
    103 Genoa Court
    SP10 5JD Andover
    Hampshire
    Director
    103 Genoa Court
    SP10 5JD Andover
    Hampshire
    BritishDirector69819850003
    HUSSAIN, Shahid
    1 Knight Orchard
    83 Verulam Road
    AL3 4DJ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    1 Knight Orchard
    83 Verulam Road
    AL3 4DJ St Albans
    Hertfordshire
    BritishComputer Consultant56263930002
    IND, Charles Thomas Messiter
    Dovehouse Street
    SW3 6JZ London
    79
    Director
    Dovehouse Street
    SW3 6JZ London
    79
    EnglandBritishInvestment Manager38539540002
    KEELER, Simon Nicholas
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    Director
    32 Dickens Drive
    Old Stratford
    MK19 6NN Milton Keynes
    EnglandBritishCompany Director79093730001
    MARSHALL, Andrew
    Haddon
    Pans Lane
    SN10 5AP Devizes
    Wiltshire
    Director
    Haddon
    Pans Lane
    SN10 5AP Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector69819890003
    MCCORMICK, David Anthony, Mr.
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    Director
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant191004740002
    PENFOUND, Steven Mark
    22 Stinchar Drive
    Chandlers Ford
    SO50 4QH Southampton
    Hedgerows
    Hants
    England
    Director
    22 Stinchar Drive
    Chandlers Ford
    SO50 4QH Southampton
    Hedgerows
    Hants
    England
    EnglandBritishDirector199014560001
    SCOTT, Graeme John
    56 Fountainhall Road
    EH9 2LP Edinburgh
    Director
    56 Fountainhall Road
    EH9 2LP Edinburgh
    ScotlandBritishDirector101636440002
    STORER, Vivian Jane
    Moseley Cottage
    Goodworth Clatford
    SP11 7RE Andover
    Hants
    Director
    Moseley Cottage
    Goodworth Clatford
    SP11 7RE Andover
    Hants
    BritishCompany Director23288660001
    VERSLUYS, Helen Louise
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    Director
    Fair Lane
    SO21 1HF Winchester
    Winnall Down
    Hampshire
    UkBritishDirector149486770001
    WALKER, Michael James
    12 Johnsons Drive
    TW12 2EQ Hampton
    Middlesex
    Director
    12 Johnsons Drive
    TW12 2EQ Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishInvestment Banker40754350001
    WILLIAMS, John Sinclair
    62 Greenacres
    Woolton Hill
    RG20 9TA Newbury
    Hants
    Director
    62 Greenacres
    Woolton Hill
    RG20 9TA Newbury
    Hants
    EnglandBritishAccountant81423620003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WINNALL DOWN FARM THREE LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr John Simon Bruce Mccowen
    Bighton
    SO24 9RD Alresford
    Manor Farm
    Hampshire
    United Kingdom
    28 feb 2018
    Bighton
    SO24 9RD Alresford
    Manor Farm
    Hampshire
    United Kingdom
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Winnall Down Farm
    Alresford Road
    SO21 1FP Winchester
    Box-It
    Hampshire
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05334086
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WINNALL DOWN FARM THREE LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 06 nov 2014
    Entregado el 14 nov 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Alexander Yew
    Transacciones
    • 14 nov 2014Registro de una carga (MR01)
    • 17 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 16 may 2012
    Entregado el 22 may 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Centric Spv 1 Limited
    Transacciones
    • 22 may 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 17 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 05 dic 2011
    Entregado el 07 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Simon Mccowen
    Transacciones
    • 07 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 17 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 25 feb 2010
    Entregado el 03 mar 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to the noteholder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P
    Transacciones
    • 03 mar 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 17 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 25 feb 2010
    Entregado el 03 mar 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 mar 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 17 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 20 oct 2008
    Entregado el 21 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Centric Spv 1 Limited
    Transacciones
    • 21 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    All assets debenture deed
    Creado el 03 ene 2003
    Entregado el 15 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 15 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 26 abr 2000
    Entregado el 09 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 06 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 15 abr 1992
    Entregado el 29 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 29 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 22 nov 1988
    Entregado el 28 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & flaoting charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 nov 1988Registro de una carga
    • 02 nov 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 09 feb 1988
    Entregado el 26 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • T.S.B. England & Wales PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1988Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 09 feb 1987
    Entregado el 10 feb 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • T.S.B. England & Wales PLC
    Transacciones
    • 10 feb 1987Registro de una carga
    • 20 nov 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0