B.V.S. RENTALS LIMITED

B.V.S. RENTALS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaB.V.S. RENTALS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01985727
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de B.V.S. RENTALS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 ene 2011

    5 páginas4.68

    Cese del nombramiento de Matthew Jowett como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Philip Harrison como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    5 páginasAA

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 páginasLIQ MISC OC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 ene 2010

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Vt House, Grange Drive Hedge End Southampton Hampshire SO30 2DQ el 15 feb 2010

    2 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Mr Matthew Paul Jowett el 15 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Philip James Harrison el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr John Richard Davies el 13 oct 2009

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 19 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 oct 2009

    Estado de capital el 27 oct 2009

    • Capital: GBP 150,000
    SH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas288c

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2008

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de B.V.S. RENTALS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAVIES, John Richard
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United KingdomBritish128289970002
    COKER, Peter John
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Crispin Field
    Pitstone
    LU7 9BG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British20675290001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secretario
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    GOWER, Angela
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    53 Chipping Vale
    Emerson Valley
    MK4 2HT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British31041710002
    HODGES, Andrew William
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    Secretario
    Flat 202
    7 Garden Walk
    EC2A 3EW London
    British77527910003
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Secretario
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British71376550001
    JOWETT, Matthew Paul
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Secretario
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    British205867540001
    RICHARDSON, Elaine
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    British36633090001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Secretario corporativo
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    COSGROVE, Peter
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    Director
    36 Grove Road
    LE10 2AD Burbage
    Leicestershire
    British33464380002
    CUNDY, Christopher John
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    Director
    74 Downscroft Gardens
    Hedge End
    SO30 4RS Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish61210490001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Director
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritish105999210001
    GREEN, Tresham Edward David
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Director
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    British20695790001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Director
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritish50619920001
    HARRISON, Philip James
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritish126366670001
    ILIC, Kosovka
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    Director
    Anesham Cottage Brownlow Avenue
    LU6 2JE Edlesborough
    Beds
    British20675310001
    JONSSON, Elizabeth Irvine Reid
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    The Spinney
    Featherbed Lane, Pathlow
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British71376550001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Director
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    British145338560001
    PRICE, David John
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Wykham Helmdon Road
    Sulgrave
    OX17 2SQ Banbury
    Oxfordshire
    British45828440002
    SIMPSON, Alan Keith
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    Director
    Watchbury Hill Hareway Lane
    Barford
    CV35 8DD Warwick
    British35940110003
    SMALE, Sarah Anne Margaret
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    2 The Green
    Longwick
    HP27 9QY Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British37137790002
    SMITH, David Michael
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    Director
    Woodlands
    Main Drive
    CV35 9BT Moreton Paddox
    Warwickshire
    British47361390001
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    Director
    The Old Rectory
    Longham
    NR19 2RG East Dereham
    Norfolk
    British145338520001
    TARRANT, Simon Edward
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    Director
    Redlands Farm
    Duncton
    GU28 0JY Petworth
    West Sussex
    British35197570012
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Director corporativo
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    AVIVA DIRECTOR SERVICES LIMITED
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Director corporativo
    St. Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    60496090003

    ¿Tiene B.V.S. RENTALS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 oct 1995
    Entregado el 10 oct 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over the benfit of hire contracts.
    Personas con derecho
    • Hitachi Credit (UK) PLC
    Transacciones
    • 10 oct 1995Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First fixed charge
    Creado el 08 oct 1993
    Entregado el 12 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase or lease agreements
    Breve descripción
    (I)all sub-lease agreements.(ii)the full benefit and advantage of the moneys payable.(iii)the benefit of all guarantees and indemnities.(iv)the benefit of all insurance.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mercedes-Benz Finance Limited
    Transacciones
    • 12 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Master agreement
    Creado el 06 jul 1993
    Entregado el 13 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee s
    Breve descripción
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreement and in all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Royscot Leasing Limited
    • Royscot Trust PLC
    • Royscot Spa Leasing Limited
    • Royscot Commercial Leasing Limited
    • Royscot Industrial Leasing Limited
    Transacciones
    • 13 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 04 ago 1987
    Entregado el 11 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the and or B.V.S. watford limited to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 ago 1987Registro de una carga
    • 06 jun 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 10 mar 1987
    Entregado el 19 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 19 mar 1987Registro de una carga
    • 03 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene B.V.S. RENTALS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 ene 2010Inicio de la liquidación
    04 ago 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0