SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)
Visión general
| Nombre de la empresa | SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 01985809 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
| Dirección de la sede social | 90 Fenchurch Street EC3M 4ST London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LAWYERS INDEMNITY MUTUAL UNDERWRITING ASSOCIATION LIMITED | 04 feb 1986 | 04 feb 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misceláneos Dissolution by c/order effective 31/01/2020 | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Orden judicial Diss by c/order ef date man gaz | 24 páginas | OC | ||||||||||
Gaceta final disuelta por instrumento jurídico | páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 33 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 37 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 32 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Paton como director el 01 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 31 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2017 au 31 dic 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016 | 35 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Patrick James Russell el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Andrew John Paton el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Christopher Jeffrey Harris el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Edward Christian John Wells el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Philip John Hope Vaughan el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Brian William Darrell Richards el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Angela Marie Horne el 04 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 jun 2016, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 jun 2015, aucune liste de membres fournie | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014 | 29 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALPENNY, Kieran Patrick | Secretario | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | British | 148244790001 | ||||||
| HARRIS, Christopher Jeffrey | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 142184450002 | |||||
| HORNE, Angela Marie | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 155506440001 | |||||
| RICHARDS, Brian William Darrell | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 21547340002 | |||||
| RUSSELL, Patrick James | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 13206950007 | |||||
| VAUGHAN, Philip John Hope | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 38959650003 | |||||
| WELLS, Edward Christian John | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 65568680002 | |||||
| JARRETT, Ian Richard | Secretario | 2 Garrard Road SM7 2ER Banstead Surrey | British | 3243820003 | ||||||
| BARKER, Christopher Shelley | Director | Lion Cottage Firbeck S81 8JT Worksop Nottinghamshire | British | 1427210001 | ||||||
| BATTEN, David Henry Cary | Director | The Keepers Cottage Ryme Intrinseca DT9 6JP Sherborne Dorset | England | British | 13365670001 | |||||
| BROOKS, Simon David | Director | 1 Hardwick Place Woburn Sands MK17 8QQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 98377180001 | ||||||
| CHALLANDS, Richard | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 45075930001 | |||||
| CROSSLEY, Peter Mortimer | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 83608220004 | |||||
| DIXON, Christopher John Arnold | Director | Forge Cottage Hurst Green RH8 9BS Oxted Surrey | British | 2504840001 | ||||||
| GOSLING, John Arthur | Director | 15 Broadwalk SK9 5PJ Wilmslow Cheshire | British | 44513610001 | ||||||
| GREEN, Christopher James | Director | 48 High Street HP16 0AU Great Missenden Buckinghamshire | British | 5057020002 | ||||||
| HAYES, Derek | Director | The Old Rectory Brook Hill Little Waltham CM3 3LJ Chelmsford Essex | England | British | 26790660002 | |||||
| HUNT, David James Fletcher, Lord Hunt Of Wirral | Director | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | England | British | 195584400004 | |||||
| LANCASTER, David Bernard | Director | Shalden Park Farm Shalden GV34 4DS Alton Hampshire | United Kingdom | British | 263055100002 | |||||
| MACCABE, Michael Murray | Director | 10 Elm Place SW7 3QJ London | British | 2846830001 | ||||||
| MALTHOUSE, Richard Harold | Director | Fair Acre Ockham Road North KT24 6NT East Horsley Surrey | British | 2430250001 | ||||||
| MCLOUGHLIN, Kevin | Director | 98 Riverdale Road S10 3FD Sheffield South Yorkshire | British | 39126020001 | ||||||
| MOSELEY, Richard John | Director | Monnow Mill House Osbaston Road NP5 4AX Monmouth Gwent | United Kingdom | British | 142446580001 | |||||
| ORCHARD, John Charles Johnson | Director | Honington Glebe Honington CV36 5AA Shipston On Stour Warwickshire | British | 13206930001 | ||||||
| PARKER, Roger John | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | England | British | 73555880002 | |||||
| PATON, Andrew John | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 133448930002 | |||||
| PAYTON, Michael Andrew Hartland | Director | 30 Bisham Gardens Highgate N6 6DD London | United Kingdom | British | 4554960001 | |||||
| PERRIN, Christopher Courtenay | Director | Fenchurch Street EC3M 4ST London 90 | United Kingdom | British | 146776090001 | |||||
| ROSENHEIM, John Frank | Director | 32 Maida Avenue Little Venice W2 1ST London | British | 106443500001 | ||||||
| RUSSELL, David Wallace | Director | Montgomery House Montgomery Road PO9 2RH Havant Hampshire | England | British | 62852230001 | |||||
| SIMSON, Peregrine Anthony Litton | Director | Corn Hall Sudbury Road CO8 5JP Bures St Mary Suffolk | British | 47409820001 | ||||||
| TAPSFIELD, Richard Harold | Director | Greenwood Gate Ewehurst Lane Speldhurst TN3 0JX Tunbridge Wells Kent | England | British | 51194340001 | |||||
| TAPSFIELD, Richard Harold | Director | Greenwood Gate Ewehurst Lane Speldhurst TN3 0JX Tunbridge Wells Kent | England | British | 51194340001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SOLICITORS INDEMNITY MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED(THE)?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 20 jun 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0