MCLEAN TW LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMCLEAN TW LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01986430
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MCLEAN TW LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra MCLEAN TW LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MCLEAN TW LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WAINHOMES LIMITED22 nov 199322 nov 1993
    WAIN GROUP PLC01 ago 199101 ago 1991
    WHELMAR GROUP PLC16 abr 198716 abr 1987
    CLEVERAIM LIMITED06 feb 198606 feb 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MCLEAN TW LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MCLEAN TW LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta08 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence22 jun 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta08 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MCLEAN TW LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Molly Banham como secretario el 29 nov 2023

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 29 nov 2023

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    10 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 01 sept 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 01 sept 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    10 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alice Hannah Black como director el 26 ago 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr. Michael Andrew Lonnon como director el 26 ago 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como secretario el 26 ago 2022

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Miss Molly Banham como secretario el 26 ago 2022

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    10 páginasAA

    Cambio de datos del director Miss Alice Hannah Marsden el 30 may 2021

    2 páginasCH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de MCLEAN TW LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    322306790001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary330353690001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    316494190001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British175715660001
    BANHAM, Molly
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    299541270001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    DE FEO, Caterina
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    Secretario
    42 The Crescent
    Hampton In Arden
    B92 0BP Solihull
    West Midlands
    British58246930001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secretario
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    INCE, David Norman
    5 Foxglove Way
    Little Neston South Wirral
    L64 0XQ Neston
    Cheshire
    Secretario
    5 Foxglove Way
    Little Neston South Wirral
    L64 0XQ Neston
    Cheshire
    British4915210001
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Secretario
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    BritishChartered Accountant62603060001
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147316970001
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Secretary116824870001
    OWEN, Stephen John
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Secretario
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    British66776040001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    AINSCOUGH, William
    Hill House Farm
    Wrightington
    WN6 9PR Wigan
    Lancashire
    Director
    Hill House Farm
    Wrightington
    WN6 9PR Wigan
    Lancashire
    BritishCompany Director18332250003
    AINSCOUGH, William
    High Moor Lane
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Harrock Hall
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    High Moor Lane
    Wrightington
    WN6 9QA Wigan
    Harrock Hall
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director18332250011
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BANNISTER, William Henry
    38 Burnbake Road
    BH31 6ET Verwood
    Dorset
    Director
    38 Burnbake Road
    BH31 6ET Verwood
    Dorset
    BritishConstruction58990140002
    BLACK, Alice Hannah
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor264031110002
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CASSIDY, John
    5 Oakwood Drive
    Prestbury
    SK10 4HG Macclesfield
    Cheshire
    Director
    5 Oakwood Drive
    Prestbury
    SK10 4HG Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director2643760002
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    DOUGLAS MANN, Stewart Charles Hamilton
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Director
    17 Queensdale Road
    W11 4SB London
    EnglandBritishDirector46258180001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Director
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    HAYWARD, Jeremy John Uphill
    11 Spylaw Park
    Colinton
    EH13 0LP Edinburgh
    Midlothian
    Director
    11 Spylaw Park
    Colinton
    EH13 0LP Edinburgh
    Midlothian
    BritishInvestment Advisor802750001
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Director
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritishCompany Director65090920001
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    JORDAN, James John
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary120602100002
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary34521340004
    MCCALLUM, Graeme Reid
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    Director
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritishCompany Director152856250001
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant115863170001
    OWEN, Stephen John
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Director
    1 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant66776040001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MCLEAN TW LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03621554
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MCLEAN TW LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge deed and deed of grant
    Creado el 24 nov 2000
    Entregado el 08 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the overage deed (as defined) and all other amounts secured by this deed
    Breve descripción
    First legal mortgage the property being land lying to the south of britannia road,morley,leeds; t/no WYK676370 and the freehold property known as land lying to the south of britannia rd,morley,leeds; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • George Armitage and Sons PLC
    Transacciones
    • 08 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 jun 2000
    Entregado el 01 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £780,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee as specified in the legal charge
    Breve descripción
    42 ashley road altrincham cheshire t/n GM832735 and all buildings and fixtures.
    Personas con derecho
    • Crosby Homes (North West) Limited
    Transacciones
    • 01 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment by way of security of interest in compensation
    Creado el 16 jun 2000
    Entregado el 23 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19TH may 2000
    Breve descripción
    All right title benefit and interest of the company in the mortgagee entitlement.
    Personas con derecho
    • Rover Investments Limited
    Transacciones
    • 23 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 16 jun 2000
    Entregado el 23 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19TH may 2000
    Breve descripción
    Land at croston road leyland lancashire.
    Personas con derecho
    • Rover Investments Limited
    Transacciones
    • 23 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 mar 2000
    Entregado el 31 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £600,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H land and property comprising part of eastfield farm launceston cornwall.
    Personas con derecho
    • Malcolm Charles Kingsley Simpson, Mark Kingsley Simpson, David Kingsley Simpson and Anthonythomas Kingsley Simpson
    Transacciones
    • 31 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 oct 1999
    Entregado el 09 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a contract dated 21ST july 1999 as varied by a supplemental agreement dated 6TH september 1999
    Breve descripción
    Rawcliffe hall hospital rawcliffe boothferry east riding yorkshire.
    Personas con derecho
    • Secretary of State for Health
    Transacciones
    • 09 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 14 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 29 sept 1999
    Entregado el 14 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 jul 1999
    Entregado el 21 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £423,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The f/h property k/a land at the convent of notre dame standish wigan lancashire.
    Personas con derecho
    • Helen Darragh
    • Notre Dame Trustee Company Limited
    • Eileen Kelleher
    Transacciones
    • 21 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 23 may 1995
    Entregado el 31 may 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 31 may 1995Registro de un cargo (395)
    • 01 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 21 feb 1992
    Entregado el 02 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of wain group PLC.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 21 feb 1992
    Entregado el 02 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balance at credit of any accounts held by the bank in name of wain group PLC.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 26 oct 1990
    Entregado el 10 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from wainhomes (lancashire) limited and/or wainhomes limited to the governor and company of the bank of scotland
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of whelmar group PLC.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 nov 1990Registro de una carga
    • 25 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 06 jun 1989
    Entregado el 12 jun 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money due or to become due from wainhomes limited and/or wainhomes (lancashire) limited to the governor & company of the bank of scotland under the terms of the charge
    Breve descripción
    All sums at the credit of whelmar group PLC's account with the governor & company of the bank of scotland.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 jun 1989Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset
    Creado el 18 oct 1988
    Entregado el 24 oct 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from whelmar developments limited and/or whelmar (north wales) limited and/or cleveraim limited and/or whelmar (chester) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The balances at credti of any accounts held by the chargee in name of whelmar group limited.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 oct 1988Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 dic 1987
    Entregado el 19 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 dic 1987Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 19 oct 1987
    Entregado el 21 oct 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Whelmar house, the beeches, plas newton lane, chester cheshire.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 oct 1987Registro de una carga
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 03 dic 1986
    Entregado el 17 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land & buildings on the north west side of plas newton lane, hoole, chester, cheshire.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 17 dic 1986Registro de una carga
    • 22 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 dic 1986
    Entregado el 05 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 05 dic 1986Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0