MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 01989264 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 10 Bishops Square E1 6EG London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MARYLEBONE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 12 sept 1986 | 12 sept 1986 |
| INTERCEDE 349 LIMITED | 13 feb 1986 | 13 feb 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Renuncia de bienes vacantes | 1 páginas | BONA | ||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Cese del nombramiento de Gavin Kenneth Tagg como director el 24 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Olsten (U.K) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cese del nombramiento de Rashida Atinuke Akinjobi como secretario el 03 nov 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Alexandra Helen Bishop como director el 16 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||
Cese del nombramiento de Yann Serge Stephane Halka como director el 06 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Daniel Miles Harris como director el 06 abr 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Alexandra Helen Bishop el 02 feb 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4BG a 10 Bishops Square London E1 6EG el 30 sept 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Yann Serge Stephane Halka el 21 ago 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Gavin Tagg como secretario el 20 feb 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Rashida Atinuke Akinjobi como secretario el 20 feb 2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mr Gavin Kenneth Tagg como director el 20 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Yann Serge Stephane Halka como director el 01 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Marcel Wolff como director el 01 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS, Daniel Miles | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | England | British | 209509320002 | |||||
| AKINJOBI, Rashida Atinuke | Secretario | Bishops Square E1 6EG London 10 England | 255582000001 | |||||||
| BARNARD, Keith | Secretario | 266 London Road AL1 1HY St Albans Hertfordshire | British | 10057550003 | ||||||
| HORWOOD, Lindsay | Secretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | British | 47473130001 | ||||||
| MCCRACKEN, Sara Benita Sophie | Secretario | Adecco House 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Hertfordshire | British | 102029890001 | ||||||
| MCCRACKEN, Sara Benita Sophie | Secretario | Flat 5 Spring Court Church Road W7 3BX London | British | 122929260001 | ||||||
| ROWLANDS, Ian Richard | Secretario | 18 Lake View Drive IRISH Moate Westmeath Republic Of Ireland | British | 119878850001 | ||||||
| SHARP, Edward James Kingsley | Secretario | Little Appleton 60 Orchard Road Tewin AL6 0HN Welwyn Hertfordshire | British | 6123350001 | ||||||
| TAGG, Gavin | Secretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | 202418700001 | |||||||
| MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED | Secretario corporativo | Elstree Way WD6 1WD Borehamwood 71 Herts | 132749860001 | |||||||
| TSC NOMINEE LIMITED | Secretario corporativo | 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Herts | 68418060004 | |||||||
| TSC RESOURCES LTD | Secretario corporativo | 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Herts | 70845340006 | |||||||
| BISHOP, Alexandra Helen | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | England | British | 183293230002 | |||||
| BRIANT, Timothy | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | United Kingdom | British | 130048920001 | |||||
| BRYCE, John | Director | Woodcotes Fears Green Sandon SG9 0QZ Buntingford Hertfordshire | British | 10407170001 | ||||||
| FREDHOLM, James William | Director | Langjurthenstrasse 6 Kusnacht Ch 8700 Switzerland | American | 111057760001 | ||||||
| GRINSTEAD, Simon Hamlin | Director | 79 Cavendish Crescent WD6 3JW Elstree Hertfordshire | South African | 61351920002 | ||||||
| HALKA, Yann Serge Stephane | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | United Kingdom | French | 255064770002 | |||||
| LILLYWHITE, Simon | Director | 11 Mitre Close Duppas Village TW17 8JF Shepperton Middlesex | British | 49450340001 | ||||||
| MACMILLAN, Richard Paul Thomas | Director | Merry Gardens Cottage Beechwood Lane, Burley BH24 4AR Ringwood Hampshire | United Kingdom | British | 82907480003 | |||||
| MARSHALL III, John Logan | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | England | American | 202761210001 | |||||
| MARTIN, Neil Thomas George | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 126681070003 | |||||
| MARTIN, Richard | Director | 80 Fulmer Rd SL9 7EG Gerrards Cross Jarretts Bucks | England | British | 92861860001 | |||||
| MCCRACKEN, Sara Benita Sophie | Director | Adecco House 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Hertfordshire | England | British | 102029890002 | |||||
| POND, Deborah Jean | Director | 313 St Albans Road West AL10 9RJ Hatfield Hertfordshire | Usa | 47456130001 | ||||||
| POZZONI, Marcello | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | United States | Italian | 235799700001 | |||||
| PYE, Ian Joseph | Director | 680 North Lakeshore Drive Apartment 1624 FOREIGN Chicago Illinois 60611 Usa | United States | British | 4259560002 | |||||
| SEARLE, Peter William | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 116102520004 | |||||
| SEARLE, Peter William | Director | Flat 4 Ravenscourt Park W6 0TY London | British | 109756550001 | ||||||
| SEYS-PHILLIPS, Nigel Godfrey Howard | Director | 19 Hasker Street SW3 2LE London | British | 30603560003 | ||||||
| SHARP, Edward James Kingsley | Director | Little Appleton 60 Orchard Road Tewin AL6 0HN Welwyn Hertfordshire | British | 6123350001 | ||||||
| TAGG, Gavin Kenneth | Director | Bishops Square E1 6EG London 10 England | England | British | 255565180001 | |||||
| VOCAT, Bruno | Director | Ch Bouvreuils 10 Pully Vaud 1009 Switzerland | British | 1416800001 | ||||||
| WOLFF, Robert Marcel | Director | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | Netherlands | Dutch | 235798570001 | |||||
| AJILON COMMUNICATIONS LTD | Director corporativo | Elstree Way WD6 1WD Borehamwood 71 Hertfordshire | 133121400001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecco Group Ag | 10 may 2016 | Bellerivestrasse 8008 Zürich 30 Che | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||||
| Olsten (U.K) Holdings Limited | 06 abr 2016 | Bishops Square E1 6EG London 10 Bishops Square England | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||||
¿Tiene MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| First fixed legal charge | Creado el 09 feb 1990 Entregado el 13 feb 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land k/a hunters court being on the north side of hunters road weldon corby northamptonshire t/no:- nn 113321 together with buildings and fixtures erected thereon (please see doc 395/m 373C/13/2 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| First fixed legal charge | Creado el 09 feb 1990 Entregado el 13 feb 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land situate off knight road strood kent k 647936 together with all buildings and fixtures erected thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 abr 1989 Entregado el 10 may 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a 3 quayside salford quays salford M5 greater manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment & charge | Creado el 04 abr 1989 Entregado el 21 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All right title benefit & interest present & future under or in connection with the leases (see form 395 ref M496C for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment | Creado el 25 mar 1988 Entregado el 07 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility d/d 15/3/88 | |
Breve descripción All right title and interests of the company in a lease agreement d/d 22/3/88. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 oct 1986 Entregado el 17 oct 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All copyrights patents inventions fees royalties etc... (see doc 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0