MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED

MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMEDECO DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01989264
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    10 Bishops Square
    E1 6EG London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MARYLEBONE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED12 sept 198612 sept 1986
    INTERCEDE 349 LIMITED13 feb 198613 feb 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Gavin Kenneth Tagg como director el 24 mar 2023

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Olsten (U.K) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 sept 2020

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Rashida Atinuke Akinjobi como secretario el 03 nov 2022

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Alexandra Helen Bishop como director el 16 ago 2021

    1 páginasTM01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Yann Serge Stephane Halka como director el 06 abr 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Daniel Miles Harris como director el 06 abr 2021

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mrs Alexandra Helen Bishop el 02 feb 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4BG a 10 Bishops Square London E1 6EG el 30 sept 2020

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Yann Serge Stephane Halka el 21 ago 2019

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Gavin Tagg como secretario el 20 feb 2019

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Ms Rashida Atinuke Akinjobi como secretario el 20 feb 2019

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Gavin Kenneth Tagg como director el 20 feb 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Yann Serge Stephane Halka como director el 01 feb 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Marcel Wolff como director el 01 feb 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARRIS, Daniel Miles
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    Director
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    EnglandBritish209509320002
    AKINJOBI, Rashida Atinuke
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    Secretario
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    255582000001
    BARNARD, Keith
    266 London Road
    AL1 1HY St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    266 London Road
    AL1 1HY St Albans
    Hertfordshire
    British10057550003
    HORWOOD, Lindsay
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    England
    Secretario
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    England
    British47473130001
    MCCRACKEN, Sara Benita Sophie
    Adecco House
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario
    Adecco House
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Hertfordshire
    British102029890001
    MCCRACKEN, Sara Benita Sophie
    Flat 5 Spring Court
    Church Road
    W7 3BX London
    Secretario
    Flat 5 Spring Court
    Church Road
    W7 3BX London
    British122929260001
    ROWLANDS, Ian Richard
    18 Lake View Drive
    IRISH Moate
    Westmeath
    Republic Of Ireland
    Secretario
    18 Lake View Drive
    IRISH Moate
    Westmeath
    Republic Of Ireland
    British119878850001
    SHARP, Edward James Kingsley
    Little Appleton 60 Orchard Road
    Tewin
    AL6 0HN Welwyn
    Hertfordshire
    Secretario
    Little Appleton 60 Orchard Road
    Tewin
    AL6 0HN Welwyn
    Hertfordshire
    British6123350001
    TAGG, Gavin
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    Secretario
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    202418700001
    MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED
    Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    71
    Herts
    Secretario corporativo
    Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    71
    Herts
    132749860001
    TSC NOMINEE LIMITED
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Herts
    Secretario corporativo
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Herts
    68418060004
    TSC RESOURCES LTD
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Herts
    Secretario corporativo
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Herts
    70845340006
    BISHOP, Alexandra Helen
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    Director
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    EnglandBritish183293230002
    BRIANT, Timothy
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    Director
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    United KingdomBritish130048920001
    BRYCE, John
    Woodcotes
    Fears Green Sandon
    SG9 0QZ Buntingford
    Hertfordshire
    Director
    Woodcotes
    Fears Green Sandon
    SG9 0QZ Buntingford
    Hertfordshire
    British10407170001
    FREDHOLM, James William
    Langjurthenstrasse 6
    Kusnacht
    Ch 8700
    Switzerland
    Director
    Langjurthenstrasse 6
    Kusnacht
    Ch 8700
    Switzerland
    American111057760001
    GRINSTEAD, Simon Hamlin
    79 Cavendish Crescent
    WD6 3JW Elstree
    Hertfordshire
    Director
    79 Cavendish Crescent
    WD6 3JW Elstree
    Hertfordshire
    South African61351920002
    HALKA, Yann Serge Stephane
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    Director
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    United KingdomFrench255064770002
    LILLYWHITE, Simon
    11 Mitre Close
    Duppas Village
    TW17 8JF Shepperton
    Middlesex
    Director
    11 Mitre Close
    Duppas Village
    TW17 8JF Shepperton
    Middlesex
    British49450340001
    MACMILLAN, Richard Paul Thomas
    Merry Gardens Cottage
    Beechwood Lane, Burley
    BH24 4AR Ringwood
    Hampshire
    Director
    Merry Gardens Cottage
    Beechwood Lane, Burley
    BH24 4AR Ringwood
    Hampshire
    United KingdomBritish82907480003
    MARSHALL III, John Logan
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    Director
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    EnglandAmerican202761210001
    MARTIN, Neil Thomas George
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    England
    Director
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    England
    EnglandBritish126681070003
    MARTIN, Richard
    80 Fulmer Rd
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Jarretts
    Bucks
    Director
    80 Fulmer Rd
    SL9 7EG Gerrards Cross
    Jarretts
    Bucks
    EnglandBritish92861860001
    MCCRACKEN, Sara Benita Sophie
    Adecco House
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Hertfordshire
    Director
    Adecco House
    71 Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritish102029890002
    POND, Deborah Jean
    313 St Albans Road West
    AL10 9RJ Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    313 St Albans Road West
    AL10 9RJ Hatfield
    Hertfordshire
    Usa47456130001
    POZZONI, Marcello
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    Director
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    United StatesItalian235799700001
    PYE, Ian Joseph
    680 North Lakeshore Drive
    Apartment 1624
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60611
    Usa
    Director
    680 North Lakeshore Drive
    Apartment 1624
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60611
    Usa
    United StatesBritish4259560002
    SEARLE, Peter William
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    England
    Director
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    England
    EnglandBritish116102520004
    SEARLE, Peter William
    Flat 4
    Ravenscourt Park
    W6 0TY London
    Director
    Flat 4
    Ravenscourt Park
    W6 0TY London
    British109756550001
    SEYS-PHILLIPS, Nigel Godfrey Howard
    19 Hasker Street
    SW3 2LE London
    Director
    19 Hasker Street
    SW3 2LE London
    British30603560003
    SHARP, Edward James Kingsley
    Little Appleton 60 Orchard Road
    Tewin
    AL6 0HN Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    Little Appleton 60 Orchard Road
    Tewin
    AL6 0HN Welwyn
    Hertfordshire
    British6123350001
    TAGG, Gavin Kenneth
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    Director
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10
    England
    EnglandBritish255565180001
    VOCAT, Bruno
    Ch Bouvreuils 10
    Pully
    Vaud 1009
    Switzerland
    Director
    Ch Bouvreuils 10
    Pully
    Vaud 1009
    Switzerland
    British1416800001
    WOLFF, Robert Marcel
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    Director
    2 Lambeth Hill
    EC4V 4BG London
    Millennium Bridge House
    NetherlandsDutch235798570001
    AJILON COMMUNICATIONS LTD
    Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    71
    Hertfordshire
    Director corporativo
    Elstree Way
    WD6 1WD Borehamwood
    71
    Hertfordshire
    133121400001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Adecco Group Ag
    Bellerivestrasse
    8008 Zürich
    30
    Che
    10 may 2016
    Bellerivestrasse
    8008 Zürich
    30
    Che
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroSwitzerland
    Autoridad legalSwiss Law
    Lugar de registroConfederation Suisse Uid Register@ Fso
    Número de registroChe-107.031.232
    Buscar en el registro mercantil suizo (Zefix)Adecco Group Ag
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Olsten (U.K) Holdings Limited
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10 Bishops Square
    England
    06 abr 2016
    Bishops Square
    E1 6EG London
    10 Bishops Square
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroWales Company Registry
    Número de registro02547754
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    First fixed legal charge
    Creado el 09 feb 1990
    Entregado el 13 feb 1990
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land k/a hunters court being on the north side of hunters road weldon corby northamptonshire t/no:- nn 113321 together with buildings and fixtures erected thereon (please see doc 395/m 373C/13/2 for full details).
    Personas con derecho
    • Swiss Volksbank
    Transacciones
    • 13 feb 1990Registro de una carga
    First fixed legal charge
    Creado el 09 feb 1990
    Entregado el 13 feb 1990
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land situate off knight road strood kent k 647936 together with all buildings and fixtures erected thereon.
    Personas con derecho
    • Swiss Volksbank
    Transacciones
    • 13 feb 1990Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 27 abr 1989
    Entregado el 10 may 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a 3 quayside salford quays salford M5 greater manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 may 1989Registro de una carga
    • 22 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment & charge
    Creado el 04 abr 1989
    Entregado el 21 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title benefit & interest present & future under or in connection with the leases (see form 395 ref M496C for full details).
    Personas con derecho
    • Okobank Osuuspankkien Keskuspankki Oy
    Transacciones
    • 21 abr 1989Registro de una carga
    • 05 oct 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 25 mar 1988
    Entregado el 07 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility d/d 15/3/88
    Breve descripción
    All right title and interests of the company in a lease agreement d/d 22/3/88.
    Personas con derecho
    • Brown Shipley & Co Limited
    Transacciones
    • 07 abr 1988Registro de una carga
    • 19 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 oct 1986
    Entregado el 17 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All copyrights patents inventions fees royalties etc... (see doc 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Inspectorate International Investeringen B.V.
    Transacciones
    • 17 oct 1986Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0