ARRIVA SOUTHEND LIMITED

ARRIVA SOUTHEND LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARRIVA SOUTHEND LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01992873
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARRIVA SOUTHEND LIMITED?

    • Otros transportes terrestres de pasajeros urbano, suburbano o metropolitano (no metro ni sistemas similares) (49319) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra ARRIVA SOUTHEND LIMITED?

    Dirección de la sede social
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARRIVA SOUTHEND LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOUTHEND TRANSPORT LIMITED24 feb 198624 feb 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARRIVA SOUTHEND LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARRIVA SOUTHEND LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13
    Q65V619K

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP a 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor York North Yorkshire YO30 4XG el 13 jul 2016

    2 páginasAD01
    A59UG4E9

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600
    A59UG4CP

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 jun 2016

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70
    A59UG4D5

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 may 2016

    Estado de capital el 03 may 2016

    • Capital: GBP 1,854,000
    SH01
    X567HBE9

    Cancelación total de la carga 18

    2 páginasMR04
    X54TPSJ2

    Cancelación total de la carga 19

    1 páginasMR04
    X54TPSEY

    Cese del nombramiento de Heath Williams como director el 30 mar 2016

    1 páginasTM01
    X53VAG9E

    Cese del nombramiento de Beverley Elizabeth Lawson como director el 30 mar 2016

    1 páginasTM01
    X53VAFW8

    Nombramiento de Lorna Edwards como director el 30 mar 2016

    2 páginasAP01
    X53VAFW0

    Cese del nombramiento de Richard Anthony Bowler como director el 22 dic 2015

    1 páginasTM01
    X4MRY3NC

    Cese del nombramiento de Kevin Paul Hawkins como director el 30 sept 2015

    1 páginasTM01
    X4H16KDC

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    9 páginasAA
    A4DASO5S

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 may 2015

    Estado de capital el 05 may 2015

    • Capital: GBP 1,854,000
    SH01
    X46RD8YL

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    19 páginasAA
    A3H3UC1K

    Cese del nombramiento de Brian Barraclough como director el 06 ago 2014

    1 páginasTM01
    X3DP4NXF

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 may 2014

    Estado de capital el 07 may 2014

    • Capital: GBP 1,854,000
    SH01
    X37F2BLD

    Nombramiento de Lorna Edwards como secretario

    2 páginasAP03
    X2NHO3W0

    Cese del nombramiento de Elizabeth Davies como secretario

    1 páginasTM02
    X2NHO3EY

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    20 páginasAA
    A2HN2OB6

    Cambio de datos del director Mr Richard Anthony Bowler el 16 ago 2013

    2 páginasCH01
    X2EUVCSI

    Cese del nombramiento de Mark Bowd como director

    1 páginasTM01
    X2EUUR4Z

    Cancelación total de la carga 20

    21 páginasMR04
    A2DFQ774

    ¿Quiénes son los directivos de ARRIVA SOUTHEND LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Secretario
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    183745400001
    EDWARDS, Lorna
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    Director
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director205425080001
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Secretario
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    HODGETTS, Robert Ian
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    Secretario
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    EnglishCompany Director29310460002
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    Secretario
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    BritishCompany Director67540260001
    SHLACKMAN, David Harold
    61 Leitrim Avenue
    Shoeburyness
    SS3 9HE Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    61 Leitrim Avenue
    Shoeburyness
    SS3 9HE Southend On Sea
    Essex
    British20149660001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Secretario corporativo
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BARKER, Neil James
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    Director
    50 Woodfield Road
    B13 9UJ Kings Heath
    Birmingham
    EnglandBritishCompany Director165014000001
    BARRACLOUGH, Brian
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector63708760003
    BARTON, William John
    38 Central Avenue
    SS2 5HS Southend On Sea
    Essex
    Director
    38 Central Avenue
    SS2 5HS Southend On Sea
    Essex
    BritishBus Driver29559930001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Director
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director42058550001
    BOWD, Mark Antony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director204447910001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director35116070003
    CARR, Sally Jane
    42 Marcus Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3LA Southend On Sea
    Essex
    Director
    42 Marcus Avenue
    Thorpe Bay
    SS1 3LA Southend On Sea
    Essex
    EnglandBritishHead Of Junior School78475080001
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Director
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director46866840005
    DUNN, Jean, Councillor Mrs
    28 Bournemouth Park Road
    SS2 5LN Southend On Sea
    Essex
    Director
    28 Bournemouth Park Road
    SS2 5LN Southend On Sea
    Essex
    BritishRetired29559880001
    FERNS, Stephen John
    17 Moxom Avenue
    Cheshunt
    EN8 9RN Waltham Cross
    Hertfordshire
    Director
    17 Moxom Avenue
    Cheshunt
    EN8 9RN Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishOperations Director69767310001
    HAWKINS, Kevin Paul
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director46684820002
    HILL, Peter William
    11 Yarnacott
    Shoeburyness
    SS3 8AL Southend On Sea
    Essex
    Director
    11 Yarnacott
    Shoeburyness
    SS3 8AL Southend On Sea
    Essex
    BritishDirector Of Engineering29559940001
    HODGETTS, Robert Ian
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    Director
    10 Harewood Close
    RH2 0HE Reigate
    Surrey
    United KingdomEnglishCompany Director29310460002
    HORRIGAN, Gwendoline Mary, Coucillor Mrs
    15 Hazelwood Grove
    SS9 4DE Leigh On Sea
    Essex
    Director
    15 Hazelwood Grove
    SS9 4DE Leigh On Sea
    Essex
    BritishRetired29559860001
    HOWARTH, Mark Burnley
    23 Hertford Road
    SS8 0EN Canvey Island
    Essex
    Director
    23 Hertford Road
    SS8 0EN Canvey Island
    Essex
    BritishTraffic And Commercial Director30309940001
    JOHNSTONE, David Graham
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    Director
    7 Pont Haugh
    Eland Mews Ponteland
    NE20 9XD Newcastle Upon Tyne
    BritishDirector Group Tax95834280001
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Director
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director77984700001
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    1 Admiral Way Doxford
    International Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishFinance Director67540260001
    LAWSON, Beverley Elizabeth
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    Director
    41 Rook Lane
    CR3 5AP Chaldon
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director67540260001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Director
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    MALLAM, Christopher
    3 Cockethurst Close
    SS0 0DU Westcliff On Sea
    Essex
    Director
    3 Cockethurst Close
    SS0 0DU Westcliff On Sea
    Essex
    United KingdomBritishOffice Manager29559870001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director6874440001
    NORTH, Anthony Stephen, Councillor Mr
    127 Church Road
    Shoeburyness
    SS3 9EZ Southend On Sea
    Essex
    Director
    127 Church Road
    Shoeburyness
    SS3 9EZ Southend On Sea
    Essex
    BritishSchoolmaster29559890001
    PIPER, John Peter
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director34903290001
    PIPER, John Peter
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    6 Sandown Close
    TN2 4RL Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director34903290001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Director
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001
    SALMON, Steven John
    7 Harvey Road
    GU1 3SG Guildford
    Surrey
    Director
    7 Harvey Road
    GU1 3SG Guildford
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director33835770001

    ¿Tiene ARRIVA SOUTHEND LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 10 oct 2008
    Entregado el 17 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgagor assigns by way of security and charges with full title guarantee all of its right title and interest in the goods specified in the schedule please see form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 26 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 19 may 2008
    Entregado el 22 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The goods T820NMJ 12995 dennis T821NMJ 12994 dennis T822NMJ 12990 dennis arriva southend limited, for further items charged please see form 395 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 23 nov 2006
    Entregado el 02 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in the goods being chassis: 14020 vdl reg no: YE06 hpx. Chassis type: SB120. Bodywork: wrightbus. Body type: cadet. Chassis: 14021 vdl reg no: YE06 hpy. Chassis type: SB121. Bodywork: wrightbus. Body type: cadet. Chassis: 14022 vdl reg no: YE06 hpz. Chassis type: SB122. Bodywork: wrightbus. Body type: cadet.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transacciones
    • 02 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 13 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 15 sept 1997
    Entregado el 24 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee the obligations on the part of the company to sell the property mortgaged or charged pursuant to an agreement dated 15TH september 1997
    Breve descripción
    F/H interest of the company in the property k/a bus depot 87 london road southend on sea essex.
    Personas con derecho
    • Grantchester Group PLC
    Transacciones
    • 24 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of charge and set-off over credit balances
    Creado el 15 ago 1994
    Entregado el 31 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994
    Breve descripción
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 11 ago 1994
    Entregado el 26 ago 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge).
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston"the Agent"
    Transacciones
    • 26 ago 1994Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 05 ago 1993
    Entregado el 19 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the north of london road southend on sea essex t/no EX363827. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 15 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from branksome (169) limited to the chargee under or in respect of the sale & purchase agreement dated 24/6/93 and all monies due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee & debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Southend on Sea Borough Council
    Transacciones
    • 15 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & charge
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 15 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from branksome (169) limited to the chargee under or I8N respect of clause 5.3 of the sale & purchase agreement dated 26/6/93 and all monies due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee & charge
    Breve descripción
    The companys right title & interest in & to all rights & claims in relation to the property & any policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Southend on Sea Borough Council
    Transacciones
    • 15 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 14 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from branksome (169) limited to the chargee under or in respect of the sale & purchase agreement dated 24/6/93 and all monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee & debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Southend on Sea Borough Council
    Transacciones
    • 14 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & charge
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 14 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due from branksome (169) limited to southend on sea borough council under or in respect of clause 5.3 of the sale & purchase agreement dated 24/6/93 and all monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the guarantee & charge
    Breve descripción
    F/H property k/a the bus depot london road southend on sea. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Southend on Sea Borough Council
    Transacciones
    • 14 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 24 jun 1993
    Entregado el 08 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A credit agreement
    Creado el 22 mar 1993
    Entregado el 03 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £168217.50 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descripción
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 03 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sixth debenture
    Creado el 16 mar 1992
    Entregado el 20 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £100,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The undertaking & all property & assets other than its f/h property k/a tickfield avenue depot.
    Personas con derecho
    • Southend-on-Sea Borough Council
    Transacciones
    • 20 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 31 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 jun 1990
    Entregado el 05 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £80,000 due or to become due from the company to the chargee.
    Breve descripción
    All property excluding site of tickfield avenue depot southend.
    Personas con derecho
    • Southend-on-Sea Borough Council
    Transacciones
    • 05 jul 1990Registro de una carga
    • 31 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 jul 1989
    Entregado el 28 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £79,000
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Southend-on-Sea Borough Council
    Transacciones
    • 28 jul 1989Registro de una carga
    • 31 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 abr 1988
    Entregado el 28 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £350,000
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future except its f/h property k/a tickfield avenue depot but including f/h property k/a london road depot southend-on-sea.
    Personas con derecho
    • Southend on-Sea Borough Council
    Transacciones
    • 28 abr 1988Registro de una carga
    • 30 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 dic 1987
    Entregado el 15 dic 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Tickfield avenue depot, at the rear of properties in crowborough rd and tickfield ave. Southend on sea. Essex.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 dic 1987Registro de una carga
    • 31 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 sept 1987
    Entregado el 18 sept 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the debenture dated 12.12.86.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Southend on-Sea Borough Council
    Transacciones
    • 18 sept 1987Registro de una carga
    • 31 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 dic 1986
    Entregado el 15 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £486,000 pursuant to a scheme of transfer made under section 68 of the transport act 1985
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Southend on-Sea Borough Council
    Transacciones
    • 15 dic 1986Registro de una carga
    • 31 jul 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ARRIVA SOUTHEND LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 jun 2016Inicio de la liquidación
    17 ago 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Profesional
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0