BRIGHTSEA EN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRIGHTSEA EN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 01996143
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRIGHTSEA EN LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EVANS NORTHERN LIMITED12 abr 199112 abr 1991
    COUNTY PROPERTIES (SUNDERLAND) LIMITED17 jul 198617 jul 1986
    MARCHLARK LIMITED05 mar 198605 mar 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01
    A2K5BYPV

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 sept 2013

    Estado de capital el 03 sept 2013

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01
    X2G2IYBD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    12 páginasAA
    L1OGZN4B

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    X1IBO8DT

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    13 páginasAA
    A0P837G3

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2011

    6 páginasAR01
    X4DNXYNJ

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    15 páginasAA
    LALI6R94

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010

    6 páginasAR01
    XDG0NNMM

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    15 páginasAA
    LLKZ3LXA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Christopher George White el 01 may 2010

    3 páginasCH01
    A1G1MJTQ

    Cambio de datos del director Mr Maurice Moses Benady el 01 may 2010

    3 páginasCH01
    A1GWEJTD

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    15 páginasAA
    LVT18FVS

    legacy

    4 páginas363a
    XC19HDAN

    legacy

    1 páginas288b
    AUPIK5XX

    legacy

    2 páginas288a
    AUPIL5XY

    legacy

    4 páginas288a
    AUPIM5XZ

    legacy

    4 páginas288a
    AUPIN5X0

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) quoted 10/11/2008
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de BRIGHTSEA EN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secretario corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Director
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Director
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister-At-Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Secretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Secretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector2748600001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishDirector84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Director
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector7095590001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Director
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    BritishDirector40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector5387660001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishEstate Director15578740001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Director
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Director
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritishAccountant58693930003
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Director corporativo
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ¿Tiene BRIGHTSEA EN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 19 sept 2007
    Entregado el 26 sept 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transacciones
    • 26 sept 2007Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 14 jun 2005
    Entregado el 18 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land k/a land and buildings on the east side of mill lane, winwick quay, warrington t/nos. CH211305 and CH211306 together with all buildings, fixtures and fittings, fixed plant and machinery from time to time therein or thereon and the proceeds of sale of the same.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Security Agent and Trustee for Itself and the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 18 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creado el 28 ene 2002
    Entregado el 01 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 of evans of leeds limited (formerly of leeds PLC) and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 20TH spetember 1995 and deeds (all as defined in the deed of release and substitution and defined on the form 395) all of which are supplemental to the trust deed dated 20TH september 1985
    Breve descripción
    Land at the east side of mill lane warrington cheshire t/nos CH211305 and CH211306 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transacciones
    • 01 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guarantee and mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Creado el 03 ago 1999
    Entregado el 16 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors (as defined) or any of them to any of the beneficiaries (as defined) including all monies obligations and liabilities due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (as defined) (or any of them) and/or on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creado el 04 dic 1992
    Entregado el 08 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £87,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all othedr monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    Signal house waterloo place sunderland tyne and wear. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transacciones
    • 08 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 24 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 03 mar 1988
    Entregado el 14 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land between waterloop place and holmside sunderland tyne and wear title no TY200642 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1988Registro de una carga
    • 25 mar 1992Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 16 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 23 ene 1987
    Entregado el 29 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All benefit of the building agreement dated 19/9/86.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 1987Registro de una carga
    • 16 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0