CASSELL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CASSELL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02004498 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CASSELL LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CASSELL LIMITED?
| Dirección de la sede social | Carmelite House 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASSELL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TESTOPTION PUBLIC LIMITED COMPANY | 26 mar 1986 | 26 mar 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CASSELL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASSELL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2019 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 130 Park Drive, Milton Park Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SE England a Hachette Uk Distribution Milton Road Didcot OX11 7HH | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 oct 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 130 Park Drive, Milton Park Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SE | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Pierre De Cacqueray el 15 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Pierre De Cacqueray el 13 abr 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Pierre De Cacqueray el 13 abr 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Orion House 5 Upper Saint Martins Lane London WC2H 9EA a Carmelite House 50 Victoria Embankment London EC4Y 0DZ el 13 abr 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Pierre De Cacqueray como secretario el 20 mar 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rowena Swallow como secretario el 20 mar 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CASSELL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CACQUERAY, Pierre | Secretario | 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London Carmelite House England | 196054920001 | |||||||
| DE CACQUERAY, Pierre | Director | 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London Carmelite House England | England | French | 101089070002 | |||||
| DASS, Pardip | Secretario | 90 Primrose Avenue RM6 4QD Romford Essex | British | 109629050001 | ||||||
| JARVIS, Clare | Secretario | Orion House 5 Upper Saint Martins Lane WC2H 9EA London | 160846790001 | |||||||
| O'SULLIVAN, Matthew | Secretario | 23 Palmerston Road East Sheen SW14 7QA London | British | 46307060001 | ||||||
| OLIVER, Ian Andrew | Secretario | 175 Wickham Chase BR4 0BH West Wickham Kent | British | 71274770001 | ||||||
| PRIOR, Mark | Secretario | 38 Merton Road SW18 1QX London | British | 105616980001 | ||||||
| RONEY, Francis John | Secretario | 88 Woodford Crescent HA5 3TY Pinner Middlesex | British | 20431110001 | ||||||
| SWALLOW, Rowena | Secretario | Orion House 5 Upper Saint Martins Lane WC2H 9EA London | 179506830001 | |||||||
| BINNIE, Stewart John | Director | 36 Glebe Road Barnes SW13 0EA London | England | British | 131771340001 | |||||
| CHEETHAM, Anthony John Valerian | Director | 8 Morpeth Mansions Morpeth Terrace SW1 1ER London | United Kingdom | British | 104796990001 | |||||
| JAEGER, Stephen Owen | Director | 11 Topstone Road Redding Connecticut 06896 FOREIGN Usa | American | 59629570001 | ||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Director | Deeracres Lisle Court Road SO41 5SH Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 8426370002 | |||||
| O'SULLIVAN, Matthew | Director | 23 Palmerston Road East Sheen SW14 7QA London | British | 46307060001 | ||||||
| ROCHE, Peter Charles Kenneth | Director | 20 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Field House Surrey | United Kingdom | British | 5584640002 | |||||
| RONEY, Francis John | Director | 88 Woodford Crescent HA5 3TY Pinner Middlesex | British | 20431110001 | ||||||
| STURROCK, Philip James | Director | Flat 14 11 Avenue Road AL1 3QG St Albans Hertfordshire | British | 42327750001 | ||||||
| SWALLOW, Rowena Gay | Director | Orion House 5 Upper Saint Martins Lane WC2H 9EA London | England | British | 179492200001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CASSELL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Orion Publishing Group Limited | 06 abr 2016 | Victoria Embankment EC4Y 0DZ London 50 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CASSELL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creado el 05 oct 1992 Entregado el 16 oct 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 09 jul 1991 Entregado el 20 jul 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 26 mar 1990 Entregado el 04 abr 1990 | Parcialmente satisfecho | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Instrument | Creado el 26 may 1989 Entregado el 06 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £2,444,300 secured loan stock 1991/1995 due from the company to the stock holders under the terms of the charge. | |
Breve descripción Undertaking, property & assets, goodwill including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 mar 1987 Entregado el 17 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £2,083,000 and all other monies due or to become due in respect of loan stock 1990/1994 pursuant tothe terms of the instrument dated 4/3/87. | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 ago 1986 Entregado el 01 sept 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0