CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02005951 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Two Snowhill Snowhill Queensway B4 6GA Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE HOMES SOUTHERN LIMITED | 01 mar 1989 | 01 mar 1989 |
| CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED | 02 abr 1986 | 02 abr 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidaci ón | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 14 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Two Snowhill Snowhill Queensway Birmingham B4 6GA el 25 ene 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ United Kingdom a Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Richard Clapham como secretario el 05 dic 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 05 dic 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Robert Andrew como director el 17 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Colin Richard Clapham como director el 17 jul 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219943480001 | |||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Other | 135438270002 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Secretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HILL, Timothy John | Secretario | 7 Claremont Gardens Purbrook PO7 5LL Waterlooville Hampshire | British | 47617100002 | ||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| PHILLIPS, James | Secretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| WHITE, Ian Michael | Secretario | 4 Garden Close Knowle B93 9QF Solihull West Midlands | British | 10543120002 | ||||||
| ANDREW, Peter Robert | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| BURTON, Anthony William Rawes | Director | Foxs Hangout Mislingford Road SO32 2QD Swanmore Hampshire | England | British | 75468170001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Director | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | 130306120001 | |||||
| FLOWER, Terry Victor | Director | 30 Apsley Grove Dorridge B93 8QP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 75464950001 | |||||
| FRESHNEY, Michael John | Director | Apple Orchard 136 Brox Road Ottershaw KT16 0LG Chertsey Surrey | England | British | 45689190001 | |||||
| GROVE, Eric William | Director | The Rye House Catesby Lane Lapworth B94 5QY Solihull West Midlands | England | British | 632880001 | |||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Director | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HOUGH, Timothy | Director | 5 Barton Drive Knowle B93 0PE Solihull West Midlands | British | 38408080002 | ||||||
| JENKINS, Stephen Adrian | Director | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 49738660003 | |||||
| JORDAN, James John | Director | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | 120602100002 | |||||
| MCCALLUM, Graeme Reid | Director | The Poplars Whinfield Road Dodford B61 9BG Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | 152856250001 | |||||
| MILLS, Stanley | Director | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | 573140004 | ||||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Director | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| PEACOCK, Raymond Anthony | Director | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | 75750250002 | |||||
| PHILLIPS, James | Director | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| REDFERN, Peter Timothy | Director | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | 74208670003 | ||||||
| SUTCLIFFE, Ian Calvert | Director | Windlesham Lodge Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | United Kingdom | British | 112534590002 | |||||
| WHITE, Ian Michael | Director | 4 Garden Close Knowle B93 9QF Solihull West Midlands | British | 10543120002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mca Holdings Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of composite guarantee and debenture | Creado el 29 oct 1991 Entregado el 06 nov 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £10,000,000 and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the loan agreement dated 29/10/91 | |
Breve descripción All stocks, shares, bonds and securities and all other interests, the undertaking and all freehold and leasehold property and any other options (see doc M579 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Creado el 30 nov 1988 Entregado el 06 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Sequitable mortgage | Creado el 21 jun 1988 Entregado el 23 jun 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 186/196 ashley road parkstone poole dorset with all buildings & fixtures. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable mortgage | Creado el 09 jun 1988 Entregado el 23 jun 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/Hold property k/a land formerly forming part of chalk pit farm whitepanish wiltshire together with all buildings & fixtures. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 28 mar 1988 Entregado el 05 abr 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land on east side of telegraph road, west end southampton. Title no: hp 317775. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Memo of deposit | Creado el 30 sept 1987 Entregado el 01 oct 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Land lying to the north east of abbey road west moors wimborne dorset. Title no dt 130559 ayalea restaurant ringwood road west moors wimborne dorset title no dt 130882 41 abbey road west moors wimborne dorset title no dt 126066. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 06 ene 1987 Entregado el 07 ene 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Plots 8,10,11 & 12 avon park off hum road ashley heath, ringwood hampshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 26 nov 1986 Entregado el 02 dic 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Plots 3-7 avon park off hurn road, ashley heath, ringwood, hampshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 29 sept 1986 Entregado el 03 oct 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Area 2.8 phases 2 & 3 chandler's ford growth area, test valley, hampshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0