CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED

CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCANBERRA (SOUTHERN) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02005951
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Two Snowhill
    Snowhill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ALFRED MCALPINE HOMES SOUTHERN LIMITED01 mar 198901 mar 1989
    CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED02 abr 198602 abr 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    14 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Two Snowhill Snowhill Queensway Birmingham B4 6GA el 25 ene 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 dic 2018

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 01 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ United Kingdom a Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Colin Richard Clapham como secretario el 05 dic 2016

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como secretario el 05 dic 2016

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 ene 2016

    Estado de capital el 04 ene 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 páginasAD03

    Cese del nombramiento de Peter Robert Andrew como director el 17 jul 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Colin Richard Clapham como director el 17 jul 2015

    2 páginasAP01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 páginasAD02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ene 2015

    Estado de capital el 13 ene 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2014

    Estado de capital el 06 ene 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    219943480001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish9684390001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34521340004
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Secretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Other135438270002
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Secretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    HILL, Timothy John
    7 Claremont Gardens
    Purbrook
    PO7 5LL Waterlooville
    Hampshire
    Secretario
    7 Claremont Gardens
    Purbrook
    PO7 5LL Waterlooville
    Hampshire
    British47617100002
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Secretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Secretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    WHITE, Ian Michael
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    Secretario
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    British10543120002
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish113503830003
    BURTON, Anthony William Rawes
    Foxs Hangout
    Mislingford Road
    SO32 2QD Swanmore
    Hampshire
    Director
    Foxs Hangout
    Mislingford Road
    SO32 2QD Swanmore
    Hampshire
    EnglandBritish75468170001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish125216670001
    CARR, Peter Anthony
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    Director
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish130306120001
    FLOWER, Terry Victor
    30 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    West Midlands
    Director
    30 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish75464950001
    FRESHNEY, Michael John
    Apple Orchard 136 Brox Road
    Ottershaw
    KT16 0LG Chertsey
    Surrey
    Director
    Apple Orchard 136 Brox Road
    Ottershaw
    KT16 0LG Chertsey
    Surrey
    EnglandBritish45689190001
    GROVE, Eric William
    The Rye House
    Catesby Lane Lapworth
    B94 5QY Solihull
    West Midlands
    Director
    The Rye House
    Catesby Lane Lapworth
    B94 5QY Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish632880001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Director
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    British76844970003
    HOUGH, Timothy
    5 Barton Drive
    Knowle
    B93 0PE Solihull
    West Midlands
    Director
    5 Barton Drive
    Knowle
    B93 0PE Solihull
    West Midlands
    British38408080002
    JENKINS, Stephen Adrian
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    Director
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish49738660003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Director
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritish120602100002
    MCCALLUM, Graeme Reid
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    Director
    The Poplars
    Whinfield Road Dodford
    B61 9BG Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritish152856250001
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Director
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    British573140004
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Director
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    British115863170001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Director
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritish75750250002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    British8364990001
    REDFERN, Peter Timothy
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    Director
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    British74208670003
    SUTCLIFFE, Ian Calvert
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Director
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish112534590002
    WHITE, Ian Michael
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    Director
    4 Garden Close
    Knowle
    B93 9QF Solihull
    West Midlands
    British10543120002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mca Holdings Limited
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House (England And Wales)
    Número de registro1152419
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of composite guarantee and debenture
    Creado el 29 oct 1991
    Entregado el 06 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £10,000,000 and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the loan agreement dated 29/10/91
    Breve descripción
    All stocks, shares, bonds and securities and all other interests, the undertaking and all freehold and leasehold property and any other options (see doc M579 for full details).
    Personas con derecho
    • Alfred Mcalpine PLC
    Transacciones
    • 06 nov 1991Registro de una carga
    Composite guarantee & debenture
    Creado el 30 nov 1988
    Entregado el 06 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland & the Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 dic 1988Registro de una carga
    • 07 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sequitable mortgage
    Creado el 21 jun 1988
    Entregado el 23 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    186/196 ashley road parkstone poole dorset with all buildings & fixtures.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jun 1988Registro de una carga
    Equitable mortgage
    Creado el 09 jun 1988
    Entregado el 23 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property k/a land formerly forming part of chalk pit farm whitepanish wiltshire together with all buildings & fixtures.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jun 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 28 mar 1988
    Entregado el 05 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on east side of telegraph road, west end southampton. Title no: hp 317775.
    Personas con derecho
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transacciones
    • 05 abr 1988Registro de una carga
    Memo of deposit
    Creado el 30 sept 1987
    Entregado el 01 oct 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land lying to the north east of abbey road west moors wimborne dorset. Title no dt 130559 ayalea restaurant ringwood road west moors wimborne dorset title no dt 130882 41 abbey road west moors wimborne dorset title no dt 126066.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 oct 1987Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 06 ene 1987
    Entregado el 07 ene 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plots 8,10,11 & 12 avon park off hum road ashley heath, ringwood hampshire.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ene 1987Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 26 nov 1986
    Entregado el 02 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plots 3-7 avon park off hurn road, ashley heath, ringwood, hampshire.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 02 dic 1986Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 29 sept 1986
    Entregado el 03 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Area 2.8 phases 2 & 3 chandler's ford growth area, test valley, hampshire.
    Personas con derecho
    • Chartered Trust PLC
    Transacciones
    • 03 oct 1986Registro de una carga

    ¿Tiene CANBERRA (SOUTHERN) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 abr 2020Fecha prevista de disolución
    17 dic 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Profesional
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0