GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02006409
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    • (5530) /

    ¿Dónde se encuentra GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GROUPE CHEZ GERARD LIMITED09 sept 199109 sept 1991
    LAKEBIRD LEISURE LIMITED13 jun 198613 jun 1986
    LAKEBIND LIMITED03 abr 198603 abr 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 ene 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    GAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    32 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 oct 2013

    26 páginas4.68

    Informe de progreso del administrador hasta 23 oct 2012

    35 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 22 may 2012

    39 páginas2.24B

    Declaración de la propuesta del administrador

    61 páginas2.17B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    61 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    15 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de * 8-10 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH* el 05 dic 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Provision of articles hereby revoked 29/09/2011
    RES13
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 sept 2011

    • Capital: GBP 15,992,000
    4 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 sept 2011

    • Capital: GBP 492,000.0
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 ene 2011

    20 páginasAA

    legacy

    10 páginasMG01

    Nombramiento de Mr Stephen Rushworth Smith como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de William Rollason como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 15 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Exercice comptable en cours prolongé du 29 jun 2010 au 29 dic 2010

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr William Rollason como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon George Rowe como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Phillips como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Hill como secretario

    2 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROWE, Simon George
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    Director
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Director
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Secretario
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    GAMBLE, Stephen
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    Secretario
    92 Bressey Grove
    South Woodford
    E18 2HX London
    British106836430001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Secretario
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Secretario
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    British130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Secretario
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Secretario
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    British2996380001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ABRAHAM, Neville Victor
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    Director
    Avenue Louise 368
    1050 Bruxelles
    Belgium
    British10579160003
    ABRAHAM, Neville Victor
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    Director
    82 Addison Road
    W14 8ED London
    United KingdomBritish10579160002
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Director
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    BERTORELLI, Adrian Peter
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    Director
    2 Bayhurst Drive
    HA6 3SA Northwood
    Middlesex
    British15898860001
    BINDER, Simon
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    Director
    Flat 89
    15 Portman Square
    W1H 6LL London
    United KingdomBritish97451910001
    BROWN, Christopher Niall Bridgmore
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    Director
    Mallards
    Spade Oak Reach
    SL6 9RQ Cookham
    Berkshire
    EnglandBritish99369900001
    DA COSTA, Michael Phillip
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    Director
    Flat 4 Saint John's Lodge
    Harley Road
    NW3 3BY London
    British26140900002
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Director
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    EDWARDS, Terence David
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    Director
    29 Morley Road
    SM3 9LN Sutton
    Surrey
    British15898850001
    ENGLISH, Tina
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    Director
    8 Kensington Court Place
    Kensington
    W8 5BJ London
    British98725570001
    FARROW, Edmund John
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    Director
    4 Park View 31 Chivalry Road
    SW11 1HT London
    British51885010001
    GARDNER, Douglas Charles
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    27 Balcombe Road
    RH16 1NZ Haywards Heath
    West Sussex
    British75225920001
    HAND, Alan
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Director
    Ivy Cottage
    3 St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    Irish102272320001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Director
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    HOLDER, Ian Keith
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    Director
    39a Great Percy Street
    WC1X 9RD London
    British60759970001
    ISAACSON, Laurence Ivor
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    Director
    5 Chalcot Crescent
    NW1 8YE London
    United KingdomBritish2996380001
    JELFFS-SHUCKBURGH, Deborah Ann
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    Director
    6 Brook Valley
    Mid Holmwood
    RH5 4EZ Dorking
    Surrey
    British77499800001
    LEDERER, John David
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    Director
    272 Lillie Road
    SE6 7PX London
    United KingdomBritish86140390001
    MCKAY, Nicholas Adrian Richard
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    Director
    48 Rawlings Street
    Chelsea
    SW3 2LS London
    British14633330001
    MILNER, Pauline Alice
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    Director
    31 Roupell Street
    SE1 8TB London
    United KingdomBritish51885090002
    MIRRELSON, Joseph Bernard
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    Director
    107 Cheyne Walk
    SW10 0DJ Chelsea
    London
    British40430150001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Director
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    PHILLIPS, Mark Randall
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    Director
    Scotts Cottage
    Scots Lane
    MK18 2HX Adstock
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80508130001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Director
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    WHITLEY, Clare Elizabeth
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    Director
    42 Cornwall Gardens
    SW7 4AA London
    British48012620002

    ¿Tiene GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A supplemental security, accession and confirmation deed
    Creado el 22 sept 2011
    Entregado el 28 sept 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The chargor, with full title guarantee, in favour of the security trustee (as trustee for the finance parties), hereby respectively charged on the terms set out in the relevant charging clause of the relevant security documents its assets as more specifically referred to in the relevant security documents, the secured liabilities see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 sept 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 17 jul 2009
    Entregado el 27 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 jul 2009Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 28 sept 2006
    Entregado el 05 oct 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each security provider to the senior finance parties and the mezzanine finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2006Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 15 dic 2005
    Entregado el 17 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Units 35, 36 and 45 the market covent garden london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 17 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 22 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creado el 15 dic 2005
    Entregado el 16 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgaged property being unit 35, 36 and 45 the market covent garden london, the plant and machinery, any goodwill, rental and other money payable and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Starlight Investments Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 28 sept 2005
    Entregado el 05 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property at 1 watling street, st paul's, london t/no NGL800172. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 05 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 ago 2005
    Entregado el 02 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 6 whitehouse apartments, 9 belvedere road, southbank t/n TGL165663, hasilwood house, 60/64 bishopsgate t/n NGL751095 and 119/120 chancery lane t/n NGL767272 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transacciones
    • 02 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 may 2005
    Entregado el 27 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 05 nov 2003
    Entregado el 15 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £62,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    An account set up pursuant to a rent deposit deed.
    Personas con derecho
    • Personal Pension Management Limited
    Transacciones
    • 15 nov 2003Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 02 may 2003
    Entregado el 09 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 oct 2001
    Entregado el 30 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 oct 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 24 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Transfer deed
    Creado el 29 oct 1993
    Entregado el 15 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charges upon; all the property and/or assets of the company listed on the schedule together with all buildings,fixtures and fixed plant and machinery. All other present and f/h and l/h property of the company all the company's present and future goodwill and uncalled capital. Floating charges upon all theundertaking and assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 ago 1989
    Entregado el 22 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Part basement ground & first floors 11/13 frith st. & 3/5 bateman st. London W1 with fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 22 ago 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 ago 1989
    Entregado el 22 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Ground floor & basement 39, panton st. London SW1 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 22 ago 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 14 ago 1989
    Entregado el 22 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    44A & 44B floral street london WC2 fixed plant machinery & other fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 22 ago 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 ago 1989
    Entregado el 17 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 17 ago 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 17 jul 1989
    Entregado el 21 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Twenties publis house, 39, ranelagh grove, london, SW1.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 21 jul 1989Registro de una carga
    • 09 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 17 jul 1989
    Entregado el 20 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Part ground floor and whole of basement, 119/120 chancery lane, london WC2. Together with the fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 20 jul 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 17 jul 1989
    Entregado el 20 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Part 31 dover street london W1 t/n ngl 339791 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 20 jul 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 17 jul 1989
    Entregado el 20 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    8 charlotte street, fitzroy square, st pancras, london W1. T/n 64653 together with fixed plant, machinery and other fixtures goodwill of the business if any and stocks of building materials.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 20 jul 1989Registro de una carga
    • 19 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 feb 1988
    Entregado el 26 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    44A floral street london WC2.
    Transacciones
    • 26 feb 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 26 feb 1988
    Entregado el 26 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    11-13 frith street london W1.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1988Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 26 feb 1988
    Entregado el 26 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    39 panton street london SW1.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1988Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 15 feb 1988
    Entregado el 26 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 feb 1988Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 12 ago 1987
    Entregado el 26 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/as being 11/13 frith street and 3/5 bateman street, london W1 including the entirley of the property comprised is a lease dated 14.10.86 of all buildings & fixtures thereon & by way of assignment the goodwill of the business carried on at the above property & the full benefit of all present and future licences held in connection with the said business or any other business carried on at the above.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 1987Registro de una carga

    ¿Tiene GROUPE CHEZ GERARD RESTAURANTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 nov 2011Inicio de la administración
    24 oct 2012Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    FechaTipo
    24 oct 2012Inicio de la liquidación
    16 ago 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Matthew David Smith
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Nicholas Guy Edwards
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0