SUPERIOR FOOD LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSUPERIOR FOOD LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02006417
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SUPERIOR FOOD LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SUPERIOR FOODS LIMITED02 may 199602 may 1996
    SPURHART LIMITED03 abr 198603 abr 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Martin Johnson como director el 03 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Diarmuid Brendan Conifrey como director el 24 jun 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Diarmuid Brendan Conifrey como director el 08 abr 2020

    2 páginasAP01

    Orden judicial

    S1096 Court Order to Rectify
    6 páginasOC

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    22 páginasAA

    legacy

    páginasANNOTATION

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2017

    22 páginasAA

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    47 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2017 au 30 sept 2017

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    29 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Mark Ian Tentori como director el 27 abr 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gavin Cox como secretario el 08 mar 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Gavin Eliot Cox como director el 07 mar 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Martin Johnson como director el 25 feb 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 feb 2016

    Estado de capital el 09 feb 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nombramiento de Mr Mark Ian Tentori como director el 06 oct 2015

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Agreement 25/09/2015
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Secretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756710001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Secretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500890001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Secretario corporativo
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Director
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrish268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Director
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Director
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Director
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Director
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish140167360001
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Director
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Director
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Director
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Director
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Director
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Director
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Director
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Director
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Director
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British17581780001
    SWAINSTON, Keith Graham
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    19 Bedford Street
    SG5 2JG Hitchin
    Hertfordshire
    British81821290001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritish119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Director
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Director
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Director
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Director
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SUPERIOR FOOD LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Superior Food Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 abr 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies
    Número de registro05288249
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene SUPERIOR FOOD LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 05 mar 2015
    Entregado el 11 mar 2015
    Pendiente
    Breve descripción
    None.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 11 mar 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 31 may 2013
    Entregado el 07 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to superior food limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of superior food limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 07 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 10 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 31 may 2013
    Entregado el 05 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transacciones
    • 05 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 06 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 11 abr 2012
    Entregado el 14 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 07 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 11 abr 2012
    Entregado el 14 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transacciones
    • 14 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 07 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 abr 2008
    Entregado el 02 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 02 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture accession deed
    Creado el 16 feb 2007
    Entregado el 05 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transacciones
    • 05 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 14 mar 2006
    Entregado el 01 abr 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The tenant's interest in all the monies standing to the credit of the account including all interest accruing thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Brixton (Great Western,Southall) 1 Limited
    Transacciones
    • 01 abr 2006Registro de un cargo (395)
    Chattel mortgage
    Creado el 31 ene 2006
    Entregado el 09 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 home counties storage system 17D mezzanine floor, 1 home counties storage system 17C mezzanine floor, 1 ima cooling system cold room 17A, for details of further chattels charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 09 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 08 ene 2004
    Entregado el 10 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 10 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 23 mar 1999
    Entregado el 01 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 abr 1994
    Entregado el 05 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 abr 1994
    Entregado el 05 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 4 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 abr 1994
    Entregado el 05 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 2 featherstone industrial estate, 15 dominion road, southall, l/b of ealing. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 05 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 16 feb 1994
    Entregado el 19 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 19 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 26 jul 1990
    Entregado el 31 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a unit 8 featherstone industrial estate dominion road southall middx and/or proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 1990Registro de una carga
    • 03 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 08 sept 1989
    Entregado el 29 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit number 2 feather stone industrial estate southall L.B. of ealing unit number of feather stone industrial estate southall L.B. of ealing and proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 sept 1989Registro de una carga
    • 03 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0