BUTLER RESEARCH LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BUTLER RESEARCH LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02007668 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BUTLER RESEARCH LIMITED?
- Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra BUTLER RESEARCH LIMITED?
| Dirección de la sede social | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BUTLER RESEARCH LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BUTLER CONSULTING GROUP LIMITED | 30 may 1997 | 30 may 1997 |
| BUTLER PUBLISHING LIMITED | 30 may 1996 | 30 may 1996 |
| BUTLER CONSULTING GROUP LIMITED | 25 abr 1995 | 25 abr 1995 |
| MG BUTLER ASSOCIATES LIMITED | 03 abr 1991 | 03 abr 1991 |
| TERNLODGE LIMITED | 08 abr 1986 | 08 abr 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BUTLER RESEARCH LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BUTLER RESEARCH LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Emily Louise Martin el 03 ago 2012 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Rupert John Joseph Hopley el 01 mar 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Rupert John Joseph Hopley como director el 01 nov 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rachel Elizabeth Jacobs como director el 16 sept 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John William Burton como director el 31 ago 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gareth Richard Wright el 19 ago 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Emily Louise Martin como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Kerswell como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Bradley como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Peter Stephen Rigby el 05 oct 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 05 oct 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 27 sept 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director John William Burton el 11 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Rachel Jacobs como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Gareth Richard Wright como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Miss Julie Louise Wilson el 02 dic 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mark Henry Kerswell el 02 dic 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BUTLER RESEARCH LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Emily Louise | Secretario | 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House United Kingdom | 160502840001 | |||||||
| WOOLLARD, Julie Louise | Secretario | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | British | 139159370002 | ||||||
| HOPLEY, Rupert John Joseph | Director | 6300 Zug Gubelstrasse 11 Switzerland | Switzerland | British | 164632060002 | |||||
| RIGBY, Peter Stephen | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 69164290007 | |||||
| WALKER, Adam Christopher | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 129368430002 | |||||
| WRIGHT, Gareth Richard | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 131115190002 | |||||
| BRADLEY, Stephen John | Secretario | Northend Bungalow North End Road HU17 8QA Bishop Burton East Yorkshire | British | 186484450001 | ||||||
| BUTLER, Carol | Secretario | 250 Beverley Road Anlaby HU10 7BD Hull North Humberside | British | 21775540001 | ||||||
| BUTLER SMITH, Stuart Michael Bruce | Secretario | 18 Fielding Road W4 1HL London | British | 67453450002 | ||||||
| DAYKIN, Michael Richard | Secretario | Weydon Hill Road GU9 8NZ Farnham 94 Surrey | British | 59323480003 | ||||||
| GILCHRIST, Andrew Iain | Secretario | The Penthouse 61 Randolph Avenue W9 1DW London | British | 89940590001 | ||||||
| O'CONNELL, Kevin Francis | Secretario | 135 Queens Road TW11 0LZ Teddington Middlesex | Irish | 108189910001 | ||||||
| RICHMOND, Sonia Anna | Secretario | 8 Viscount Gardens KT14 6HE Byfleet Surrey | British | 118535490002 | ||||||
| THRESH, John Harold, Director | Secretario | Aspen House Beverley Road YO25 7RX Driffield North Humberside | British | 5909310001 | ||||||
| WARDEN, John Henderson | Secretario | Fairfield Silverdale Crescent S11 9JH Sheffield | British | 59501490001 | ||||||
| DATAMONITOR SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Charles House 108-110 Finchley Road NW3 5JJ London | 116374750001 | |||||||
| BECKER, Maximilian Nicolas Thomas Bibra | Director | 14 Eagle Wharf 138 Grosvenor Road SW1V 3JS London | British | 110699760001 | ||||||
| BRADLEY, Stephen John | Director | Northend Bungalow North End Road HU17 8QA Bishop Burton East Yorkshire | England | British | 186484450001 | |||||
| BURTON, John William | Director | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London | United Kingdom | British | 113684810001 | |||||
| BUTLER, Martin Gordon | Director | Amblegales Sunny Mede Avenue HP5 3LE Chesham Buckinghamshire | British | 60292460003 | ||||||
| BUTLER SMITH, Stuart Michael Bruce | Director | 18 Fielding Road W4 1HL London | British | 67453450002 | ||||||
| DANSON, Michael Thomas | Director | Charles House 108-110 Finchley Road Swiss Cottage NW3 5JJ London | British | 16134990006 | ||||||
| FOYE, Anthony Martin | Director | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | United Kingdom | British | 99515780001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Director | Casa Maria Spaniard's End Hampstead NW3 7JG London | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| GILCHRIST, Andrew Iain | Director | The Penthouse 61 Randolph Avenue W9 1DW London | England | British | 89940590001 | |||||
| GILES, Timothy Grant | Director | Dunglass House School Hill NN11 3HG Newnham Northamptonshire | British | 55488710001 | ||||||
| HARKNESS, Peter Martin | Director | 19 Horsley Court Montaigne Close Regency Street SW1 4BF London | United Kingdom | British | 146757430001 | |||||
| JACOBS, Rachel Elizabeth | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | United Kingdom | British | 92334500004 | |||||
| JEFFREY, Jane | Director | 9 Whitting Court Cliff Road HU13 0HB Hessle North Humberside | British | 52422950002 | ||||||
| KERSWELL, Mark Henry | Director | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 82609620003 | |||||
| PYPER, Simon John | Director | 56 Greenfield Gardens Golders Green NW2 1HY London | British | 108173190002 | ||||||
| THRESH, John Harold, Director | Director | Aspen House Beverley Road YO25 7RX Driffield North Humberside | British | 5909310001 | ||||||
| WARDEN, John Henderson | Director | Fairfield Silverdale Crescent S11 9JH Sheffield | United Kingdom | British | 59501490001 |
¿Tiene BUTLER RESEARCH LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creado el 11 jun 1993 Entregado el 17 jun 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0