LTG GATESHEAD GROUP PLC

LTG GATESHEAD GROUP PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLTG GATESHEAD GROUP PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 02010022
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Dirección de la sede social
    c/o IMAGELINX UK LTD
    Julias Way Station Park Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CRABTREE GROUP PLC21 jun 199321 jun 1993
    SOMERSET TRUST PLC10 jul 199210 jul 1992
    CHILDREN'S MEDICAL CHARITY INVESTMENT TRUST PLC14 abr 198614 abr 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Louise Palmer como director el 16 nov 2010

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 24 feb 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 mar 2012

    Estado de capital el 08 mar 2012

    • Capital: GBP 2,028,329.9
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN el 08 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 feb 2011

    13 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Albert Klein como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Albert Kenngott Klein el 01 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    11 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    7 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de LTG GATESHEAD GROUP PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Secretario
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    British119011320002
    PALMER, Louise
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    Director
    c/o Imagelinx Uk Ltd
    Lowmoor Road
    Kirkby-In-Ashfield
    NG17 7RB Nottingham
    Julias Way Station Park
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director119011320002
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Director
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritishDirector53806830002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Secretario
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Secretario
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    BritishDirector64149560002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Secretario
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director30827780001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Secretario
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    BritishFinance Director94273950001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Secretario
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    BritishAccoutant29821230002
    ROWSON, Peter Aston
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    Secretario
    Croft Lodge
    Church Lane Great Longstone
    DE45 1TB Bakewell
    Derbyshire
    British94699120001
    C S INVESTMENTS LIMITED
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    Secretario corporativo
    125 High Holborn
    WC1V 6PY London
    4852550001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Secretario corporativo
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    ARMSTRONG, Michael John Lloyd
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    Director
    Moor Mill Farm
    Lydeard,St Lawrence
    TA4 3RG Taunton
    Somerset
    BritishRetired48330740002
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Director
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    BARNETT, Joel, The Right Honourable Lord Barnett
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    Director
    7 Hillingdon Road
    Whitefield
    M45 7QQ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Secretary2883500001
    CHESSER, David
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    Director
    Dunkirk House
    Watling Street
    NE45 5AQ Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritishDirector64149560002
    COOPER, Matthew
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    Director
    Newlands
    Marchburn Lane
    NE44 6DN Riding Mill
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Secretary35122920001
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director30827780001
    FELLERMAN, Paul
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    Director
    38 Sherwood Road
    Hendon
    NW4 1AD London
    BritishStockbroker10266750001
    FLETCHER, Alan Thomas
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Director
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    BritishCompany Director14669590001
    HARGRAVE, Stephen Thomas
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    Director
    47 Lambs Conduit Street
    WC1N 3NG London
    EnglandBritishCompany Director60918490001
    HOLMES, John Edwin
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Director
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    BritishManaging Director42461820001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Director
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Director94273950001
    JOHNSON, Luke Oliver
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    Director
    28 Monmouth Road
    W2 4UT London
    BritishCompany Director56699270001
    KLEIN, Albert Kenngott
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Director
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    GermanyGermanDirector69826640001
    LEHRER, Abraham Mayir
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    Director
    13 Haslemere Gardens
    N3 3EA London
    BritishSolicitor10008800001
    LEWINSOHN, Max Robert
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    Director
    Tanyard Manor
    Horsted Lane
    RH19 4HY Sharpthorne
    Sussex
    United KingdomBritishDirector17400002
    MOWINCKEL, John Crostarosa, Mr.
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    Director
    Flat 9 30 Bramham Gardens
    SW5 0HE London
    United KingdomAmericanBanker42840430001
    NAPOLEON, Edward
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    Director
    929 N Astor 1502
    Milwaukee Wi
    53202
    Usa
    AmericanBusinessman50486960002
    ODELL, Frank William
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    Director
    7 Ham Farm Road
    Ham Common
    TW10 5ND Richmond
    Surrey
    BritishDirector2081870001
    ORR, David Alexander, Sir
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    Director
    Home Farm House
    Shackleford
    GU8 6AH Godalming
    Surrey
    BritishCompany Director38973090001
    OURY, Richard Anthony
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    Director
    Farnham Cottage
    Farnham Common Egypt Lane
    SL2 3LF Slough
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant29821230002
    PAUL, Swraj, Dr
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    Director
    Caparo House 103 Baker Street
    W1M 1FD London
    BritishDirector40016170001
    PERLOFF, Andrew Stewart
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    Director
    Friars Mead Barnet Lane
    Elstree
    WD6 3RA Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director1474150001
    ROGERS, Douglas Ernest
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Director
    46 Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director32445690002
    STEVENSON, Samuel
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    Director
    149 Pavilion Road
    SW1X 0BJ London
    BritishDirector2506760001

    ¿Tiene LTG GATESHEAD GROUP PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental deed between the company (1) crabtree holdings (us) limited (2) crabtree holdings limited (3) crabtree of gateshead limited (4) and landesbank baden-wurttenberg (the bank) (2)
    Creado el 12 jul 1999
    Entregado el 02 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    (A) the secured parties have made available to the companies a loan facility of up to dem 19,800,000 on the terms set out in a facility agreement (the" crabtree facilities agreement") dated 11 november 1998 made between the companies as borrower (1) ltg technologies PLC as guarantor (2) and the chargee (3) for the purpose of refinancing existing loan facilities of the companies.(b) the obligations of the companies to the secured parties under or pursuant to inter alia the crabtree facilities agreement are secured by a composite guarantee and debenture dated 15 december 1998
    Breve descripción
    Pursuant to the supplemental deed the debenture has been amended so that schedule 2 (properties),schedule 3 (fixed plant and machinery) and schedule 4 (intellectual property rights) to the debenture are deleted in their entirety and replaced by the respective schedules set out in annexure a of the supplemental deed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Landesbank Baden-Wurttenberg (The Successor Entity Following the Merger on 1 January 1999 of Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse,Sudwestdeutsche Landesbank Girozentrale and Landeskreditbank Baden Wurttenberg)
    Transacciones
    • 02 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture between crabtree group PLC (1), crabtree holdings (us) limited (2), crabtree holdings limited (3), crabtree of gateshead limited (4) and landesgirokasse offentliche bank und landessparkasse (the "chargee")(5)
    Creado el 15 dic 1998
    Entregado el 22 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to the "secured documents" (as defined) together and each as it may from time to time be amended varied novated supplemented or replaced
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landesgirokasse Offentliche Bank Und Landessparkasse
    Transacciones
    • 22 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 nov 1995
    Entregado el 05 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 05 dic 1995Registro de un cargo (395)
    • 18 nov 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 13 oct 1993
    Entregado el 28 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the deposits, together with all interest from time to time accruing thereon, details of charged deposit contract(s)-barclays bank PLC re spmerset trust PLC (now called crabtree group PLC) gts bid deposit bid number 7568760 (for full details see form 395).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 oct 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 23 jul 1993
    Entregado el 12 ago 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all the "deposit (s)", together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged account(s)-barclays bank PLC re crabtree group PLC, bid deposit bid no: 62011466 (for full details see from 395).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ago 1993Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 21 jun 1993
    Entregado el 12 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Barclays bank PLC re somerset trust PLC gts bid deposit bid no 7568760. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 09 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0