QUADRO HARSTON LIMITED

QUADRO HARSTON LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaQUADRO HARSTON LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02015785
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de QUADRO HARSTON LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
    • Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra QUADRO HARSTON LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUADRO HARSTON LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SAGENTIA TECHNOLOGY ADVISORY LIMITED20 feb 201420 feb 2014
    SAGENTIA HOLDINGS LIMITED17 mar 200817 mar 2008
    SAGENTIA GROUP LIMITED20 oct 200620 oct 2006
    THE GENERICS GROUP LIMITED17 jul 199017 jul 1990
    GENERICS HOLDINGS CORPORATION LIMITED05 dic 198605 dic 1986
    EQUALHOLD LIMITED30 abr 198630 abr 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de QUADRO HARSTON LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para QUADRO HARSTON LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence25 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUADRO HARSTON LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cambio de datos del director Miss Sarah Elizabeth Cole el 09 dic 2024

    2 páginasCH01

    Memorándum y Estatutos

    4 páginasMA

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    30 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    30 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    30 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 020157850008, creada el 23 dic 2021

    109 páginasMR01

    Cese del nombramiento de Sameet Vohra como director el 30 jul 2021

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 020157850007, creada el 11 ago 2021

    29 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    20 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jonathan Brett como director el 23 jul 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Miss Sarah Elizabeth Cole el 21 may 2021

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name23 jun 2021

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 23 jun 2021

    RES15

    Cese del nombramiento de Rebecca Anne Archer como director el 09 abr 2021

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 09 mar 2021

    • Capital: GBP 0.25
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem reserve 17/02/2021
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de QUADRO HARSTON LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COLE, Sarah Elizabeth
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Secretario
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    185002290001
    BRETT, Jonathan
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Director
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant204193690001
    COLE, Sarah Elizabeth
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Director
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishSolicitor158070400004
    EDWARDS, Daniel Robert Morgan
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Director
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector173639950002
    BARRETT HAGUE, Helen Patricia
    Westward Farm
    The Green
    PE28 5PP Winwick
    Cambridgeshire
    Secretario
    Westward Farm
    The Green
    PE28 5PP Winwick
    Cambridgeshire
    British96466480004
    ELTON, Neil
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    Secretario
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    153206470001
    FARMER, David
    12 Cherry Orchard
    Fulbourn
    CB1 5EH Cambridge
    Secretario
    12 Cherry Orchard
    Fulbourn
    CB1 5EH Cambridge
    British33510150002
    FROST, Martin John
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    Secretario
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    BritishAccountant153090450001
    MARAN, Roger
    12 Clarence Gate Gardens
    NW1 6AY London
    Secretario
    12 Clarence Gate Gardens
    NW1 6AY London
    British9888620001
    MCCARTHY, Guy Jonathan
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    Secretario
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    British128742040001
    ARCHER, Rebecca Anne
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    Director
    Harston Mill, Harston
    Cambridge
    CB22 7GG Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector185002210010
    BROWN, Alistair John Cameron, Dr
    The Grange Old Pembroke Farm
    21c High Street Burwell
    CB25 0HB Cambridge
    Director
    The Grange Old Pembroke Farm
    21c High Street Burwell
    CB25 0HB Cambridge
    BritishConsultant119604540002
    CLARK, Mark Thomas
    26 Worcester Avenue
    CB3 7XG Hardwick
    Cambridgeshire
    Director
    26 Worcester Avenue
    CB3 7XG Hardwick
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishHead Of It88370060001
    COGGILL, Christopher John
    55 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    Director
    55 High Street
    West Wratting
    CB1 5LU Cambridge
    BritishEconomist14659410001
    COLLINS, Ian Peter
    27 Madingley Road
    CB3 0EG Cambridge
    Director
    27 Madingley Road
    CB3 0EG Cambridge
    United KingdomBritishEngineer41679610002
    CROSSFIELD, Michael, Dr
    Perne Drift Burton End
    West Wickham
    CB1 6SD Cambridge
    Cambridgesgire
    Director
    Perne Drift Burton End
    West Wickham
    CB1 6SD Cambridge
    Cambridgesgire
    BritishPhysicist47393140001
    DANNATT, Margaret Anne, Dr
    13 Church Green
    CM1 4NZ Roxwell
    Essex
    Director
    13 Church Green
    CM1 4NZ Roxwell
    Essex
    BritishHr Director84805750001
    DAVEY, Simon
    2 Windsor Way
    SG19 1JL Sandy
    Bedfordshire
    Director
    2 Windsor Way
    SG19 1JL Sandy
    Bedfordshire
    BritishConsultant83333910002
    EDGE, Gordon Malcolm
    Bishops House Church Street
    Great Chesterford
    CB10 1NP Saffron Walden
    Essex
    Director
    Bishops House Church Street
    Great Chesterford
    CB10 1NP Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritishEngineer41047030002
    ELTON, Neil Anthony
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    Director
    130 Wapping High Street
    E1W 2NH London
    23 Gun Wharf
    EnglandBritishDirector74129080002
    FAIRCLOUGH, John Whitaker, Sir
    The Old Blue Boar 25 St Johns Street
    SO23 8HF Winchester
    Hampshire
    Director
    The Old Blue Boar 25 St Johns Street
    SO23 8HF Winchester
    Hampshire
    BritishMerchant Banker14451130001
    FLICOS, Daniel James
    71 Little Walden Road
    CB10 2DL Saffron Walden
    Essex
    Director
    71 Little Walden Road
    CB10 2DL Saffron Walden
    Essex
    EnglandBritishElectronic Engineer116870120001
    FROST, Martin John
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    Director
    4 Evening Court
    Newmarket Road
    CB5 8EA Cambridge
    EnglandBritishAccountant153090450001
    GREAVES, John Richard Adam
    Manor Farm
    68 Town Street
    CB2 5PE Newton
    Cambridgeshire
    Director
    Manor Farm
    68 Town Street
    CB2 5PE Newton
    Cambridgeshire
    BritishBusiness Manager81423030001
    HINE, Duncan, Dr
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    Director
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    BritishManaging Director13396990001
    HUDSON, Brent Christopher
    The Grove
    TW11 8AT Teddington
    43
    Middlesex
    England
    Director
    The Grove
    TW11 8AT Teddington
    43
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector146460230001
    HYDE, Peter John, Dr
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    Director
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    BritishEngineer29675940001
    HYDE, Peter John, Dr
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    Director
    Caters Farm
    Cowlinge
    CB8 9HP Newmarket
    Suffolk
    BritishEngineer29675940001
    KYLBERG, Lars Vilhelm
    Ostermalmsgatan 101
    Stockholm
    Se 11549
    Sweden
    Director
    Ostermalmsgatan 101
    Stockholm
    Se 11549
    Sweden
    SwedishCompany Director95021110001
    LAWSON, Peter Gerald
    Froyls
    High Street
    RH16 2MR Lindfield
    Sussex
    Director
    Froyls
    High Street
    RH16 2MR Lindfield
    Sussex
    BritishCompany Director29675990001
    LEE, Robin Michael, Dr
    Paddock View
    30 Back Road
    CB1 6JF Linton
    Cambridgeshire
    Director
    Paddock View
    30 Back Road
    CB1 6JF Linton
    Cambridgeshire
    BritishConsultant81423140001
    LUDVIGSSON, Per Ake
    Avenue D`Hougoumont 17
    Bruxelles B1180
    Belgium
    Director
    Avenue D`Hougoumont 17
    Bruxelles B1180
    Belgium
    SwedishManaging Director76594300001
    MCCARTHY, Guy Jonathan
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    1 Cambridge Road
    Foxton
    CB22 6SH Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant128742040001
    MOODY, Peter Brian
    2 Alwyne Place
    N1 2NL London
    Director
    2 Alwyne Place
    N1 2NL London
    BritishCompany Director46801630001
    MORLAND, Robert John
    1 Mortlock Close
    SG8 6DA Melbourn
    Hertfordshire
    Director
    1 Mortlock Close
    SG8 6DA Melbourn
    Hertfordshire
    EnglandBritishEngineer118685420001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de QUADRO HARSTON LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Science Group Plc
    Royston Road
    Harston
    CB22 7GG Cambridge
    Harston Mill
    England
    06 abr 2016
    Royston Road
    Harston
    CB22 7GG Cambridge
    Harston Mill
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalThe Companies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales Companies Register
    Número de registro06536543
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene QUADRO HARSTON LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 dic 2021
    Entregado el 23 dic 2021
    Pendiente
    Breve descripción
    The properties known as land on the north west side of royston road, harston, cambridge CB22 7GG registered at hm land registry with title number CB234341 and harston mill, royston road, harston, cambridge CB22 7GG and registered at hm land registry with title number CB114439.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2021Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 11 ago 2021
    Entregado el 12 ago 2021
    Pendiente
    Breve descripción
    By legal mortgage the freehold property known as harston mill, royston road, harston, cambrodge, CB22 7GG and land on the north west side of royston road, harston (title numbers: CB114439 and CB234341).
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC (Crn: 00002065)
    Transacciones
    • 12 ago 2021Registro de una carga (MR01)
    Mortgage
    Creado el 21 jun 2006
    Entregado el 23 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a harston mill, harston, cambridge, cambridgeshire t/no CB114439 and CB234341. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 31 oct 2000
    Entregado el 15 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a approx. 8 acres of land at manor farm harston south cambridgeshire t/no;-CB234341 and the proceeds of sale thereof.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2025Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 27 jun 2000
    Entregado el 14 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a harston mill harston cambridge. T/no. CB114439. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2025Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 01 oct 1996
    Entregado el 07 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: f/h-harston mill royston road harston cambridgeshire t/n-CB114439.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 28 feb 1995
    Entregado el 09 mar 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property known as harston mill, royston road, harston, cambridgeshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 1995Registro de un cargo (395)
    • 17 ene 2025Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 13 dic 1991
    Entregado el 02 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • Coutts & Company
    Transacciones
    • 02 ene 1992Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0