GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED

GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02018842
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HATCH WARREN 1992 LIMITED15 oct 199215 oct 1992
    NULLI SECUNDUS LIMITED12 may 198612 may 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2024
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta18 jul 2025
    Próxima declaración de confirmación vence01 ago 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta18 jul 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Adam Mcghin como director el 27 sept 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Sapna Bedi Fitzgerald como secretario el 30 sept 2024

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Adam Mcghin como secretario el 27 sept 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Sapna Bedi Fitzgerald como director el 30 sept 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2023

    14 páginasAA

    legacy

    187 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cambio de datos del director Mr Adam Mcghin el 01 sept 2023

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital el 11 jul 2023

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2022

    17 páginasAA

    legacy

    176 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2021

    23 páginasAA

    Nombramiento de Richard Flynn como director el 12 sept 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 15 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Andrew Philip Saunderson como director el 26 nov 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robert Jan Hudson como director el 29 oct 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Eliza Pattinson como director el 14 oct 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    328536790001
    FITZGERALD, Sapna Bedi
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishSolicitor327770380001
    FLYNN, Richard
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishProperty Litigator211094730001
    GORDON, Helen Christine
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director59902650002
    HUDSON, Robert Jan
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director201533990002
    PATTINSON, Eliza
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector257770240001
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MCGHIN, Adam
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Secretario
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    206241900001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Secretario
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Secretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Director
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritishDirector Of Equity Release156117090001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant74581390003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Director
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishChartered Accountant65421150003
    DICKINSON, Ian Joicey
    The Manor House
    NE44 6HW Riding Mill
    Northumberland
    Director
    The Manor House
    NE44 6HW Riding Mill
    Northumberland
    BritishSolicitor8256940001
    DICKINSON, Robert Henry
    Styford Hall
    NE43 7TX Stocksfield
    Northumberland
    Director
    Styford Hall
    NE43 7TX Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritishSolicitor1509850001
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Director
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritishChartered Surveyor60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Director
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritishChartered Accountant8256950001
    EXLEY, Richard John
    Bramall
    Faircrouch Lane
    TN5 6PT Wadhurst
    East Sussex
    Director
    Bramall
    Faircrouch Lane
    TN5 6PT Wadhurst
    East Sussex
    BritishDirector Of Development141351660001
    FIELDER, James
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    Director
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    United KingdomBritishSurveyor72574940002
    GREENWOOD, Mark
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director154194730002
    JAMES, Andrew David
    Westwood House
    Ebchester
    DH8 0TD Consett
    County Durham
    Director
    Westwood House
    Ebchester
    DH8 0TD Consett
    County Durham
    United KingdomBritishDevelopment Manager46100500002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishDirector60099210003
    MCGHIN, Adam
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor169082950002
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Director
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    BritishDirector36406380001
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritishLawyer135860930002
    PRATT, Andrew Michael
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    Director
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director123314130002
    SAUNDERSON, Andrew Philip
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector178354900001
    SCRIVENER, Andrew John
    Riverview
    Ferry Road
    RG8 0JP Southstoke
    Oxfordshire
    Director
    Riverview
    Ferry Road
    RG8 0JP Southstoke
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director90919430002
    SIMMS, Vanessa Kate
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director205191690001
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Director
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    BritishChartered Surveyor94640230001
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Director
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishChartered Accountant43646700001
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Director
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishChartered Accountant43646700001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Saint. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Saint. James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England & Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00884274
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene GRAINGER HOUSING & DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Sub-charge
    Creado el 04 jul 1995
    Entregado el 25 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from grainger trust PLC to the chargee under or in respect of the "b" loan notes
    Breve descripción
    The company charges and assigns to the trustees the title numbers HP454422 and HP454423 and all of the companys rights title and interests and power arising therefrom or relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Caroline Patricia Darley
    • Rebecca Charlotte Baron as Agent and Trustee for the Vendors (As Defined)
    • Nicola Margaret Combes
    Transacciones
    • 25 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of proceeds
    Creado el 28 mar 1995
    Entregado el 11 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from grainger trust PLC (the purchaser) to caroline patricia darley (as agent and trustee for the vendors (as defined) under or in respect of the "b" loan notes (as defined) together with all expenses due or to become due supplemental to the terms of the mortgage dated 25TH october 1994 and/or this charge
    Breve descripción
    The "charged balance" for the time being on the business premium account no.80402656 In the joint names of the company and grainger investment properties limitedwith barclays bank PLC at regent centre gosforth newcastle - upon - tyne designated "hatch warren, basingstoke.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Caroline Patricia Darleyd in the Chargeas Agent and Trustee for the Vendors - as Define
    Transacciones
    • 11 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    "B"loan notes charge
    Creado el 25 oct 1994
    Entregado el 02 nov 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,obligations and liabilities due from grainger trust PLC ("the purchaser") to caroline patricia darley,nicola margaret combes and rebecca charlotte baron as trustees for and on behalf of the vendors (as defined) or any of them under or in respect of the "b"loan notes and all expenses
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all and every interest in or over the property being land at hatch warren,basingstoke l/hold t/no.HP454423 (part thereof). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Rebecca Charlotte Baron
    • Caroline Patricia Darley
    • Nicola Margaret Combes
    Transacciones
    • 02 nov 1994Registro de un cargo (395)
    • 23 sept 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Sub mortgage
    Creado el 04 feb 1993
    Entregado el 16 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the east side of long cross lane hatch warren basingstoke hampshire t/no hp 424210.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 30 sept 1992
    Entregado el 20 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over all bookdebts and other debts due or owing to the company see form for details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 sept 1992
    Entregado el 08 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    35 acres of land forming part of hatch warren farm basingstoke hampshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 05 dic 1988
    Entregado el 19 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 dic 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed
    Creado el 13 jul 1988
    Entregado el 25 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from south eastern shops & offices limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of and as defined in the royal charge d/d 13/7/88
    Breve descripción
    Any present or future rights or interests which the company may have in 526/528 fulham road london SW6.
    Personas con derecho
    • United Dominions Trust Limited
    Transacciones
    • 25 jul 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 jun 1988
    Entregado el 11 jul 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage 21, linden gardens, london. Fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 jul 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 mar 1988
    Entregado el 24 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage:- f/h dwellinghouse and premises at and k/a 26 holland park, london W11 in the royal borough at kensington and chelsea fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 mar 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 mar 1988
    Entregado el 24 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage f/h dwellinghouse and premises at and k/a number 17 holland park, london W11 in the royal borough of kensington and chelsea. Fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 24 mar 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 feb 1988
    Entregado el 01 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land 2 hillside cottages chalfont giles buckinghamshire fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 01 mar 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 81. christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 jun 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 jun 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 84 christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 jun 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 32, christchurst house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 72, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 38, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 10 christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 78, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 98 christchurch house, christchurch road brixton hill london SW2 by way of legal mortgage. Charge over all plant machinery implements utensils furniture.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 58, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 79, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 94, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 96, christchurch house christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 15 ene 1988
    Entregado el 20 ene 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage flat 97, christchurch house, christchurch road, brixton hill london SW2 charge over all plant machienry implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 1988Registro de una carga
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0