EPS MAINTENANCE LIMITED

EPS MAINTENANCE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEPS MAINTENANCE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02022463
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EPS MAINTENANCE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IPM ENGINEERING LIMITED22 may 198622 may 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del secretario Mitie Company Secretarial Services Limited el 20 ene 2014

    1 páginasCH04

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 ene 2014

    Estado de capital el 21 ene 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de 8 Monarch Court the Brooms Emersons Green Bristol BS16 7FH el 20 ene 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2013

    4 páginasAA

    Cambio de datos del director Peter Iain Maynard Skoulding el 23 ago 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2012

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Mitie Administration 2 Limited como director el 31 ene 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mitie Administration 1 Limited como director el 31 ene 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2011

    4 páginasAA

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 1 Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green Bristol England BS16 7FN

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Peter Iain Maynard Skoulding como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Clark como director

    1 páginasTM01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01

    Nombramiento de Mitie Company Secretarial Services Limited como secretario

    3 páginasAP04

    Nombramiento de Mitie Administration 2 Limited como director

    3 páginasAP02

    ¿Quiénes son los directivos de EPS MAINTENANCE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Secretario corporativo
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5228356
    148474450001
    SKOULDING, Peter Iain Maynard
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    Director
    Harlequin Office Park, Fieldfare
    Emersons Green
    BS16 7FN Bristol
    1
    England
    England
    United KingdomBritish186216730001
    GINGER, Deborah
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    British7200150002
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Secretario
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    British97375340001
    MORLEY, Nigel
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    Secretario
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    British65393440001
    RAJENDRA, George Rajkumar
    29 Higher Green
    KT17 3BB Epsom
    Surrey
    Secretario
    29 Higher Green
    KT17 3BB Epsom
    Surrey
    British4618730002
    ANDERSON, David John
    Hall Farm
    Hall Lane Shenfield
    CM15 0SH Brentwood
    Essex
    Director
    Hall Farm
    Hall Lane Shenfield
    CM15 0SH Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish65141060002
    CLARKE, James Ian
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Director
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    United KingdomBritish135276530001
    GINGER, Brian George
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    Director
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    British7200160002
    GINGER, Deborah
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    Director
    Galabrae
    32 Chevening Road, Chipstead
    TN13 2RZ Sevenoaks
    Kent
    British7200150002
    GINGER, Lee Brian
    Downs View Close
    Pratts Bottom
    BR6 7SU Orpington
    2
    Kent
    Director
    Downs View Close
    Pratts Bottom
    BR6 7SU Orpington
    2
    Kent
    British97505650002
    GRIFFIN, Peter
    12 Hurst Green Road
    RH8 9BT Oxted
    Surrey
    Director
    12 Hurst Green Road
    RH8 9BT Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish77000520001
    HOLMES, Peter James
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    Director
    Meadow View
    5a Mill Common
    PE29 3AU Huntingdon
    Cambs
    EnglandBritish97375340001
    JEFFERYS, Gary Stephen
    Apperfield Road
    Biggin Hill
    TW16 3LX Westerham
    77
    Kent
    Director
    Apperfield Road
    Biggin Hill
    TW16 3LX Westerham
    77
    Kent
    British38836490003
    LEWIS, Matthew Donald Lewis
    Apartment 4 Calverley Court
    Downs Bridge Road
    BR3 5HX Beckenham
    Kent
    Director
    Apartment 4 Calverley Court
    Downs Bridge Road
    BR3 5HX Beckenham
    Kent
    British73626100001
    MORLEY, Nigel
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    Director
    25 Applecross Close
    ME1 1SQ Rochester
    Kent
    British65393440001
    ODONNELL, James Michael
    35 The Avenue
    Highams Park
    E4 9LB London
    Director
    35 The Avenue
    Highams Park
    E4 9LB London
    British78300340001
    READER, Paul David
    8a Torrance Close
    RM11 1JT Hornchurch
    Essex
    Director
    8a Torrance Close
    RM11 1JT Hornchurch
    Essex
    British92246340002
    REEVE, Simon
    1 Forge Cottages
    Chilbrook Road
    KT11 3PD Cobham
    Surrey
    Director
    1 Forge Cottages
    Chilbrook Road
    KT11 3PD Cobham
    Surrey
    British93064280001
    ENVIRONMENTAL PROPERTY SERVICES PLC
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Director corporativo
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    64155070001
    MITIE ADMINISTRATION 1 LIMITED
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Director corporativo
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06537612
    148505960001
    MITIE ADMINISTRATION 2 LIMITED
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Director corporativo
    The Brooms
    Emersons Green
    BS16 7FH Bristol
    8 Monarch Court
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06537610
    148506020001

    ¿Tiene EPS MAINTENANCE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 19 abr 2002
    Entregado el 27 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest of eps maintenance limited in the £23,100 deposited in the interest earning deposit account designated.
    Personas con derecho
    • Jeremy Miles Allan Thompson and Jennifer Mary Thompson
    Transacciones
    • 27 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 13 ago 1999
    Entregado el 18 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 30 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 07 dic 1998
    Entregado el 21 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 mar 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 ago 1989
    Entregado el 10 ago 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ago 1989Registro de una carga
    • 27 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0