ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaASTEC COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02023193
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RANGENOW LIMITED28 may 198628 may 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Estado de capital el 10 mar 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Mrs Janine Butler como director el 23 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Nigel Evans como director el 23 feb 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2019

    9 páginasAA

    legacy

    256 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Nombramiento de Mr Andrew Michael Yorston como director el 02 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diane Josephine Mcintyre como director el 16 mar 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    5 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro2357692
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector257275320001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    Secretario
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    British77894160002
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HODGSON, Mark
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    Secretario
    3 Cochran Close
    Churchdown
    GL3 2NA Gloucester
    Gloucestershire
    British72699060001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    WRIGHT, Garth Howard
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    Secretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    England
    British130769810001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    Director
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    BritishDirector54076100002
    BARR, Robert Nicolas
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Lindfield Faringdon Road
    OX14 1BD Abingdon
    Oxfordshire
    UkBritishAccountant41968920003
    BEST, Pauline Ann
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    Director
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    BritishHuman Resources Director68015830001
    BISWAS, Sumit Kumar
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    Director
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector63870460001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Director
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Director
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    BritishDirector83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishDirector99525280001
    COTTLE, Paul
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    Director
    The Old Granary
    Brimpsfield
    GL4 8LD Gloucester
    BritishAccountant77894160002
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Director
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    BritishDirector1908570001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector64442870001
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Director
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director50867930001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Director
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritishDirector50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Director
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    BritishDirector33951180005
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishGroup Commercial Director27272400002
    HEXT, Jane Helen
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    Director
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector152305810001
    HILLHOUSE, George Reid
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    12 Churchview Drive
    Barnwood
    GL4 7ES Gloucester
    Gloucestershire
    BritishDirector2899430001
    HODGSON, Mark
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    2 Alcotts Green
    Sandhurst
    GL2 9PE Gloucester
    Gloucestershire
    BritishDirector72699060002
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Director
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Director
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritishDirector24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    MAXWELL, Ian Ronald
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    Director
    Coach House Adbury Park
    Adbury
    RG15 8HB Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director16186890001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3381659
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ASTEC COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of rent deposit
    Creado el 15 jul 1996
    Entregado el 16 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15TH july 1996
    Breve descripción
    £10,868.75 or any increased sum payable into the deposit account in the name of the landlord at lloyds babk PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ravenseft Properties Limited
    Transacciones
    • 16 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 08 jul 1996
    Entregado el 19 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,000 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of an underlease of even date
    Breve descripción
    A rent deposit of £5,000 paid under a deed dated the 8/7/96. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ravenseft Properties Limited
    Transacciones
    • 19 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 18 ago 1995
    Entregado el 05 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 12TH july 1995 and/or this deed
    Breve descripción
    £11,163.50.
    Personas con derecho
    • The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty
    Transacciones
    • 05 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 06 mar 2021Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge
    Creado el 05 sept 1994
    Entregado el 10 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company`s right title and interest in and to the subscriber base al book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 05 sept 1994
    Entregado el 07 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements dated 28/93 and 3/2/93 and/or this charge
    Breve descripción
    The interest of the company in its customers from time to time as well as after as before any receiver may be appointed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Vodafone Limited
    Transacciones
    • 07 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 sept 1994
    Entregado el 07 sept 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Vodafone Group PLC
    Transacciones
    • 07 sept 1994Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 06 feb 1991
    Entregado el 14 feb 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreements and/or this charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Telecom Securicor Cellular Radiw Limited
    Transacciones
    • 14 feb 1991Registro de una carga
    • 05 oct 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 28 jul 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge
    Creado el 17 nov 1986
    Entregado el 26 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific charge over the benefit of all leasing rental hire purchase or credit sale agreements, all bills of exchange or promissory notes, all guarantees indemnities bonds or other securities. (For full details please see form 395 ref: M173/26NOV/ln).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 nov 1986Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 oct 1986
    Entregado el 22 oct 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1986Registro de una carga
    • 06 nov 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0