HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02026572 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION PLC | 23 mar 1987 | 23 mar 1987 |
| HOUSEHOLD MORTGAGE PLC | 30 sept 1986 | 30 sept 1986 |
| HMC MORTGAGE NOTES 9 LIMITED | 25 jul 1986 | 25 jul 1986 |
| TILEBRIDGE LIMITED | 10 jun 1986 | 10 jun 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kalpna Shah como secretario el 31 ene 2018 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU el 22 dic 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard William Bird como director el 29 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Fn Mortgages Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 ago 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Notification de Fn Mortgages Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Laurence Anne Renee Perrin como director el 30 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Samantha Jones como director el 10 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bernardus Petrus Maria Van Bunnik como director el 01 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF a PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY el 23 ago 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Manuel Uria-Fernandez como director el 14 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard William Bird como director el 14 jun 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 nov 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Manuel Uria-Fernandez el 17 dic 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Mark Pickering como director el 11 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mrs Kalpna Shah como secretario el 10 jul 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Fn Secretary Limited como secretario el 10 jul 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Samantha | Director | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | United Kingdom | British | 216074420001 | |||||
| CHARD, Nicola Ruth | Secretario | 29 Ferndale Close Stokenchurch HP14 3YS High Wycombe Buckinghamshire | British | 78565310001 | ||||||
| JACOBS, Alan John | Secretario | Quainton Cottage Quainton HP22 4AY Aylesbury Buckinghamshire | British | 12263280001 | ||||||
| SHAH, Kalpna | Secretario | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | 199403690001 | |||||||
| VARLEY, Tracey Elizabeth | Secretario | 50 Woodfield Crescent W5 1PB London | British | 110323670001 | ||||||
| ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Abbey National House 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London | 61749570003 | |||||||
| FN SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | 53-61 College Road HA1 1FB Harrow Middlesex | 88740300002 | |||||||
| BAUM, Jonathan Graydon | Director | Pooh Cottage 9-11 High Street WF4 2JZ Woolley West Yorkshire | British | 89272870001 | ||||||
| BELLORA, Michael Richard | Director | Russet House 1a Latchmoor Avenue SL9 8LL Gerrards Cross Buckinghamshire | American | 98453650001 | ||||||
| BERRY, Duncan Gee | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 107695600022 | |||||
| BIRD, Richard William | Director | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | United Kingdom | British | 209298590001 | |||||
| CAMP, Ian Nigel | Director | Coombewood Rignall Road HP16 9PE Great Missenden Buckinghamshire | British | 68571410001 | ||||||
| CARSON, David Richard | Director | 26 Loynells Road Rednal B45 9NP Birmingham | British | 73271960002 | ||||||
| COUCH, Gary Charles | Director | 35 Kildare Terrace W2 5JT London | British | 52556350001 | ||||||
| DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131081660001 | |||||
| EVANS, Kellie Victoria | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 167417000001 | |||||
| FERGUSON, Ian George | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133318850001 | |||||
| FLYNN, William John | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | British | 99330320002 | ||||||
| GARDEN, Robert James | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152764360001 | |||||
| GUNNIGLE, Clodagh | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138244630002 | |||||
| HARVEY, David | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 97086950001 | |||||
| HEESE, Bruno | Director | 53-61 College Road Harrow HA1 1FB Middlesex | British | 115371680001 | ||||||
| HOLE, Jonathan Graham | Director | 8 Draytons View Greenham RG19 8SA Newbury Berkshire | British | 92873190001 | ||||||
| HOWELL, Ronald Charles George | Director | Henley House 6 Redlands Place Evendons Lane RG41 4ED Wokingham Berkshire | England | British | 75050310001 | |||||
| HUNKIN, Ricky David | Director | 2 Hockeridge View Oakwood HP4 3NB Berkhamsted Hertfordshire | British | 115390900001 | ||||||
| JOHAR, Mandeep Singh | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Indian | 127046380002 | |||||
| MELLING, Michael John | Director | Queensgate House School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 170403940001 | |||||
| MILTON, Douglas George | Director | Oakleigh Spratts Lane KT16 0HH Ottershaw Surrey | United Kingdom | British | 97140240001 | |||||
| MOORE, Andrew Geoffrey | Director | 1 Kingswood Road W4 5EU London | British | 92407170001 | ||||||
| NUTLEY, Julian Stanley | Director | 9 The Green Mentmore LU7 0QF Leighton Buzzard The Old Fox Bedfordshire | United Kingdom | British | 136696510001 | |||||
| PACKE, Maxwell Gordon | Director | Ashwater House Ewen GL7 6PZ Cirencester Gloucestershire | British | 47686490002 | ||||||
| PERRIN, Laurence Anne Renee | Director | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | United Kingdom | French | 183220720001 | |||||
| PICKERING, Steven Mark | Director | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164833430002 | |||||
| PRIEST, David Peter | Director | 5 Gables Close SL9 0PR Chalfont St Peter Buckinghamshire | England | British | 42961460001 | |||||
| PUNCH, Andrew Robert | Director | Pepys Way 6 Ford Road GU24 9EJ Bisley Surrey | United Kingdom | British | 147703850001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fn Mortgages Limited | 06 abr 2016 | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene HOUSEHOLD MORTGAGE CORPORATION LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0