RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02029313 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
- Actividades de consultoría de gestión que no sean gestión financiera (70229) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1st Floor Randstad Court Laporte Way LU4 8SB Luton Bedfordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALBEMARLE INTERIM MANAGEMENT LIMITED | 21 ene 2010 | 21 ene 2010 |
| ALBEMARLE GROUP PLC | 24 oct 1994 | 24 oct 1994 |
| ALBEMARLE CONSULTANTS LIMITED | 08 feb 1991 | 08 feb 1991 |
| ALBEMARLE SECURITIES LIMITED | 29 oct 1986 | 29 oct 1986 |
| ALBERMARLE SECURITIES LIMITED | 07 ago 1986 | 07 ago 1986 |
| ISLAND ENTERPRISES LIMITED | 18 jun 1986 | 18 jun 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 22 sept 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 13 dic 2013
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christiana Adeola Bernard como director el 28 mar 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Joseph Deamer como director el 31 ene 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 20 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 15 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Rod Jackson como director el 06 ene 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Joost Carel Sandor Gietelink como director el 19 dic 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Graham Reader como director el 19 dic 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 20 páginas | AA | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mark Jonathon Bull el 30 ago 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mark Jonathon Bull como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Brian Wilkinson como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor Regent Court Laporte Way Luton Beds LU4 8SB United Kingdom el 01 jul 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Naylor como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULL, Mark Jonathan | Director | Randstad Court Laporte Way LU4 8SB Luton 1st Floor Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 89717310001 | |||||
| GIETELINK, Joost Carel Sandor | Director | Upper Walk Virginia Park GU25 4SN Virginia Water 4 Surrey United Kingdom | United Kingdom | Netherlands | 164363820001 | |||||
| BELCHEM, Gary | Secretario | 17 Turkey Oak Close Upper Norwood SE19 2NZ London | British | 66391670002 | ||||||
| HALE, Derrick Bernard | Secretario | Dorchester Court Dexter Close AL1 5WD St Albans 35 Herts | British | 132647080001 | ||||||
| HIRD, John Charles | Secretario | 6 Ardshiel Close SW15 1EB London | British | 9558850001 | ||||||
| HORN, Alan David | Secretario | 70 The Grove MK40 3JN Bedford | British | 47516350001 | ||||||
| MEPANI, Daksha | Secretario | 46a Howberry Road HA8 6SY Edgware Middlesex | British | 76052010001 | ||||||
| NAYLOR, Ian | Secretario | Oakhill Road TN13 1NU Sevenoaks 77 Kent United Kingdom | 147428880001 | |||||||
| NEWTON-CLARE, Herbert Mitchell | Secretario | Fallowfield Hightown BH24 3HE Ringwood Hampshire | British | 9558860002 | ||||||
| WOOD, Michael Napier Vout | Secretario | 5 Townsend Leys NN10 8LW Higham Ferrers Northamptonshire | British | 79379490001 | ||||||
| BEHAN, Christopher George Vincent | Director | Hill Cottage The Green Brill HP18 9RU Aylesbury Buckinghamshire | British | 62369030001 | ||||||
| BERNARD, Christiana Adeola | Director | Green Lane AL3 6EU St. Albans Sycamore Lodge 158 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 135725020001 | |||||
| DEAMER, Kevin Joseph | Director | Richmond Close Frimley GU16 8NR Camberley 18 Surrey United Kingdom | England | British | 5734140001 | |||||
| HICKMORE, Angela Genevieve | Director | 32 Holly Grove PO16 7UP Fareham Hampshire | England | British | 74194550002 | |||||
| HIRD, John Charles | Director | 6 Ardshiel Close SW15 1EB London | British | 9558850001 | ||||||
| HOLMAN, Michael Lawrence | Director | Greensands Brassey Road Limpsfield RH8 0EU Oxted Surrey | British | 15211120001 | ||||||
| HORN, Alan David | Director | 70 The Grove MK40 3JN Bedford | England | British | 47516350001 | |||||
| IRWIN, Terence Christopher | Director | 12 Brentcot Close W13 8EH London Greater London | United Kingdom | British | 100714610001 | |||||
| JACKSON, Rod | Director | The Pound Hawstead IP29 5NJ Bury St. Edmunds Joffaca House Suffolk United Kingdom | England | Uk | 98229300002 | |||||
| MARTIN, Anthony Victor | Director | Aston Court Aston Hill HP22 5NQ Halton Buckinghamshire | United Kingdom | British | 6123340003 | |||||
| MILES, Charles Kenneth Zachary | Director | 18 Lansdowne Road TN1 2NJ Tunbridge Wells Kent | British | 39243410001 | ||||||
| NEWTON-CLARE, Herbert Mitchell | Director | Fallowfield Hightown BH24 3HE Ringwood Hampshire | British | 9558860002 | ||||||
| READER, Colin Graham | Director | 51 Arlington Road NW1 7ES London | United Kingdom | British | 3037660001 | |||||
| ROWLEY, John | Director | Hickling Lodge Melton Road LE14 3QG Hickling Pastures Leicestershire | England | British | 11900790002 | |||||
| SUGDEN, Richard Paul | Director | 12 The Slype Gustard Wood Wheathampstead AL4 8RY St Albans Hertfordshire | British | 49273690001 | ||||||
| WALKER, Roger Arthur | Director | Conigree Dock Lane, Bredon GL20 7LG Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 63790980002 | |||||
| WILKINSON, Brian | Director | The Old Mistal Newsholme Oakworth BD22 0QT Keighley West Yorkshire | United Kingdom | British | 11900780002 |
¿Tiene RANDSTAD INTERIM EXECUTIVES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 02 may 1996 Entregado el 09 may 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0