MCC LEASING (NO. 6) LIMITED

MCC LEASING (NO. 6) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMCC LEASING (NO. 6) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02030523
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    • Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginas4.71

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 1 Churchill Place London E14 5HP a Barlcays Group Archives Dallimore Road Manchester Manchester M23 9JA

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 20 nov 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 09 nov 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 01 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ago 2015

    Estado de capital el 13 ago 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Mohammed Akram como director el 13 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ene 2015

    Estado de capital el 19 ene 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    23 páginasAA

    Cancelación total de la carga 1

    6 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    6 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2014

    Estado de capital el 06 ene 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nombramiento de Gavin John Simpson como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Duncan Rowberry como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    25 páginasAA

    Nombramiento de Mohammed Akram como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Thomas Geoffrey Ridout como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    27 páginasAA

    Cese del nombramiento de Darren Hare como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Secretario corporativo
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Secretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Director
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Director
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Director
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Director
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish147858890001
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Director
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Director
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Director
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Director
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Director
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Director
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Director
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Director
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Director
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Director
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Director corporativo
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    ¿Tiene MCC LEASING (NO. 6) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Sub lease security agreement
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 14 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing the performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated 24/11/92 and from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92
    Breve descripción
    All the grantor's right title and interest as lessee in the head lease and as secured party in the head security agreement (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transacciones
    • 14 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 25 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Secondary lease security assignment
    Creado el 30 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from i/s mardron and/or tarben J.B.olesen to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Breve descripción
    All the right title and interest in and to the assigned payments and sums paid or payable in respect thereof (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    First priority statutory mortgage
    Creado el 30 jun 1987
    Entregado el 13 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or svenska handelsbanten and/or barclays bank PLC acting as agent for itself pursuant to a guarantee facility agreement dated 30/7/87
    Breve descripción
    32/64TH shares in the M.V. "st. Nicholas" registered at the port of london under official no 703472 and in her boats and appurtenances.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC and/or Svenska Handelsbanken and/or Barclays Bank PLC Actingas Agent
    Transacciones
    • 13 jul 1987Registro de una carga
    • 24 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenants
    Creado el 30 jun 1987
    Entregado el 13 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for itself and svenska handelsbanken pursuant to a guarantees facility agreement dated 30 june 1987 and this deed.
    Breve descripción
    All the right title & interest in the vessel M.V. "st nicholas" registered at the part of london official no. 703472 and all boats machinery etc. (see doc M86/14 jul/cf for full details).
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1987Registro de una carga
    • 24 abr 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene MCC LEASING (NO. 6) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 nov 2015Inicio de la liquidación
    07 jul 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0