LAMMERMUIR LEASING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LAMMERMUIR LEASING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02033887 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LAMMERMUIR LEASING LIMITED?
- Arrendamiento financiero (64910) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LAMMERMUIR LEASING LIMITED?
| Dirección de la sede social | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LAMMERMUIR LEASING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MCC LEASING (NO. 12) LIMITED | 03 jul 1986 | 03 jul 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LAMMERMUIR LEASING LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LAMMERMUIR LEASING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 4 páginas | 4.71 | ||||||||||
Presentación de insolvencia Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 páginas | LIQ MISC | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Orden judicial de insolvencia Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator | 30 páginas | LIQ MISC OC | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Winchester House 1 Great Winchester Street London EC2N 2DB a 15 Canada Square London E14 5GL el 11 abr 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 14 mar 2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Adam Paul Rutherford como secretario el 14 ago 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Chris Snailham como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 3 páginas | MISC | ||||||||||
Misceláneos S.519 compant act 2006 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Kenyon Thomas el 24 feb 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LAMMERMUIR LEASING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGSHAW, Joanne Louise | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | 180380420001 | |||||||
| BARTLETT, Andrew William | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 73852930003 | ||||||
| SNAILHAM, Christopher Charles | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British | 202149290001 | |||||
| THOMAS, David Kenyon | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House England England | United Kingdom | British | 59397060006 | |||||
| BURTON, Jennifer Sandra | Secretario | 39b Butler Avenue HA1 4EJ West Harrow Middlesex | British | 100622570001 | ||||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Secretario | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Secretario | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | British | 70451850004 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Secretario | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Secretario corporativo | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Director | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Director | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Director | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Director | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| DOWDING, Eric Robert | Director | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Director | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| GOLDSBROUGH, Christopher Andrew John | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House United Kingdom | United Kingdom | British/New Zealand | 153832500002 | |||||
| HOYLE, Stephen Lewis | Director | 2 Haslemere Road N8 9QX London | United Kingdom | British | 96838010001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Director | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 69140360003 | ||||||
| LEWIS, Barry Randall | Director | 37 Main Road Littleton SO22 6QJ Winchester Hampshire | England | British | 145163830001 | |||||
| MACFARLANE, Stuart Edward | Director | 6 Lynmouth Road East Finchley N2 9LS London | Australian | 125721120002 | ||||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Director | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MCGIDDY, Mark Andrew | Director | Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House 1 | Australian | 114990900003 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Director | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 68601920002 | ||||||
| MILLINER, Craig | Director | 21 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | 144700710001 | ||||||
| PRESS, Matthew | Director | 106 Ledbury Road W11 2AH London | Australian | 104610910001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Director | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Director | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 49237880003 | ||||||
| SILCOCK, Frank Avis | Director | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| SIVANITHY, Rajanbabu | Director | 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London Winchester House | United Kingdom | British | 63268810003 | |||||
| THOMPSON, Peter Gordon | Director | 8 Wagtail Walk Langley Park BR3 3XG Beckenham Kent | British | 61570160003 | ||||||
| VASUDEVA, Nicholas Shashi | Director | 57 Linden Gardens W2 4HJ London Flat 1 | British/Australian | 79508880002 | ||||||
| WEAL, Barry | Director | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Director | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Director corporativo | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BAROMETERS LIMITED | Director corporativo | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 57357300002 |
¿Tiene LAMMERMUIR LEASING LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Creado el 30 dic 1992 Entregado el 13 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due from i/s danwheel and/or svend arvad jensen to the bank under the terms of the loan agreement dated 30/12/92 | |
Breve descripción All right title & interest in & to the assigned payments & all sums paid or payable in respect thereof (for full details refer to doc M395 & continuation sheets). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Sublessee security agreement | Creado el 30 dic 1992 Entregado el 14 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargees under the terms of the sublease dated 24/11/92 & from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92 | |
Breve descripción All the grantors right title & interest as lessee in the head lease & as secured party in the head security agreement (for full details refer to doc M395 & continuation sheets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene LAMMERMUIR LEASING LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0