COFFEE POINT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOFFEE POINT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02037135
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COFFEE POINT LIMITED?

    • Otros servicios de alimentación (56290) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra COFFEE POINT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COFFEE POINT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CRAYGLOW LIMITED15 jul 198615 jul 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COFFEE POINT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 mar 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para COFFEE POINT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COFFEE POINT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 03 mar 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 24 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 feb 2015

    Estado de capital el 20 feb 2015

    • Capital: GBP 100,941
    SH01

    Nombramiento de Mr Kris Paul Ludo Geysels como director el 18 dic 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Brian Mackie como director el 18 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 mar 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 feb 2014

    Estado de capital el 04 feb 2014

    • Capital: GBP 100,941
    SH01

    Nombramiento de Mr Daniel Henry Abrahams como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Helen Willis como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Brian Mackie el 01 may 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    Cese del nombramiento de War Tin como secretario

    1 páginasTM02

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cese del nombramiento de War Tin como secretario

    1 páginasTM02

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 ene 2013A second filed AP01 was registered for Helen Willis

    second-filing-of-form-with-form-type

    4 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    07 ene 2013Second filed TM01 for Timothy Roe

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 abr 2012

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mrs War War Tin como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Greenwood como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Helen Margaret Willis como director

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 ene 2013A second filed AP01 was registered on the 10 January 2012

    ¿Quiénes son los directivos de COFFEE POINT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Director
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    EnglandBritish183822370001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Director
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    BelgiumBelgian193655140001
    COOK, Josephine Isabel
    White House
    Clinton Lane
    TN8 7PP Bough Beech
    Secretario
    White House
    Clinton Lane
    TN8 7PP Bough Beech
    British66475960002
    GREENWOOD, Michael Frank
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Secretario
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    British163171710001
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    TIN, War War
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Secretario
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    174470180001
    BROTHERWOOD, Tony James
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    Director
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    EnglandBritish143546010001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Director
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    EnglandBritish51864840002
    DEMBITZ, John Andrew
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    Director
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    British15837270001
    DEMBITZ, John Andrew
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    Director
    10 Crescent Road
    SW20 8EX London
    British15837270001
    DOBBS, Neil Stoker
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    Director
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    United KingdomBritish20511010001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    6 Windsor Park
    NE28 8UQ Wallsend
    Tyne & Wear
    Director
    6 Windsor Park
    NE28 8UQ Wallsend
    Tyne & Wear
    British111822640001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    Director
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    United KingdomBritish106272340001
    HUGHES, Leonard
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    Director
    50 St Margarets Street
    ME1 1TU Rochester
    Kent
    British52234370002
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    EnglandBritish28010290009
    LEWIS, Gary Kenneth
    89 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Director
    89 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    United KingdomBritish65266510002
    MACKIE, Brian
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Director
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    ScotlandBritish173446760002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish34345860002
    MURRELL, Andrew John
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    Director
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    EnglandBritish114514100001
    NAISMITH, Nicholas John Ewen
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    Director
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    British2892470011
    NEWBERRY, Charles Timothy
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Director
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandEnglish29754260005
    PRATT, Isabelle
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    Director
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    French103007770001
    PRATT, Isabelle
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    Director
    1 Vicarage Close
    Colgate
    RH12 4BB Horsham
    West Sussex
    French103007770001
    ROE, Timothy Michael
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Director
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish51264250001
    STRINGFELLOW, Robin John
    23a The Street
    Corton
    NR32 5HW Lowestoft
    Suffolk
    Director
    23a The Street
    Corton
    NR32 5HW Lowestoft
    Suffolk
    British113787560001
    THOMPSON, Peter Charles Fenton
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    Director
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    British19655110001
    THOMPSON, Peter Charles Fenton
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    Director
    Long Dawkhams Station Road
    Woldingham
    CR3 7DE Caterham
    Surrey
    British19655110001
    TRACE, Charles Lawrence
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    EnglandBritish129244340001
    TRACE, Charles Lawrence
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    Director
    Sands Lane
    Small Dole
    BN5 9YL Henfield
    Ashleigh House
    West Sussex
    EnglandBritish129244340001
    WHITELING, Mark Argent
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Director
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritish101297630001
    WILLIS, Helen Margaret
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Director
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    United KingdomBritish277089380001

    ¿Tiene COFFEE POINT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Master assignment
    Creado el 16 nov 2005
    Entregado el 29 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All monies due and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Universal Leasing Limited
    Transacciones
    • 29 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 26 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over shares
    Creado el 05 mar 2004
    Entregado el 12 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The shares and security assets and includes any proceeds of sale or other realisation thereof or any part thereof, shares 14,940 ordinary shares in the share capital of sk automatics limited (no. 1394004).
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 12 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 11 feb 2003
    Entregado el 19 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares and security assets and any proceeds of sale or other realisation thereof and all stocks,securities,rights,money or other property and bonus,dividend and interest accruing thereon.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 19 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 feb 2003
    Entregado el 14 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 14 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 11 feb 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 04 ene 2002
    Entregado el 08 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 24 june 1991 issued by the company
    Creado el 26 jun 2000
    Entregado el 30 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Breve descripción
    By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 4 may 1995 between confidential invoice discounting limited and the company and any deed amending or replacing the same (all such deeds being hereinafter called the charged deeds) and all book debts and other debts the subject of the charged deeds as and when the same shall become due or owing to the company upon re-vesting in the company whether pursuant to the charged deeds or otherwise.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 15 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 sept 1999
    Entregado el 30 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transacciones
    • 30 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 jun 1991
    Entregado el 03 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 1991Registro de una carga
    • 10 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 10 nov 1988
    Entregado el 17 nov 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 nov 1988Registro de una carga
    • 09 ago 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 09 ago 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene COFFEE POINT LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    03 mar 2015Inicio de la liquidación
    22 mar 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0