RUBY DCO TEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRUBY DCO TEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02040018
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RUBY DCO TEN LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RUBY DCO TEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Office 5, International House
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MEDIMART LIMITED23 jul 198623 jul 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUBY DCO TEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cessation de Admenta Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2023

    1 páginasPSC07

    Notification de Dunamis Mind Accelerator Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2023

    2 páginasPSC02

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re: change of name / company shall be entitled to appoint a sole director / such director shall have the authority to exercise all powers and discretions of the directors confered by the articles 31/08/2023
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Thorsten Sprank como director el 31 ago 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Graham Wiseman como director el 31 ago 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Dominik Muser como director el 31 ago 2023

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX a Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS el 04 sept 2023

    1 páginasAD01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed medimart LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name04 sept 2023

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 ago 2023

    RES15

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 ago 2023

    • Capital: GBP 630,001
    3 páginasSH01

    Estado de capital el 29 ago 2023

    • Capital: GBP 0.0001
    5 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share premium 29/08/2023
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Nombramiento de Mr Dominik Muser como director el 06 jul 2023

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 25 ene 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    3 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resoluciones

    Re-removal of restriction on authorised shares capital 07/09/2022
    RES13
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    33 páginasMA

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Cese del nombramiento de Wendy Margaret Hall como director el 09 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nichola Louise Legg como secretario el 09 sept 2022

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPRANK, Thorsten
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Director
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Secretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    MURPHY, Francis Joseph
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    Secretario
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    British32866430003
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    TWAROWSKI, Maria Elizabeth
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    British47378310001
    BARCLAY, Raymond Dunbar
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    Director
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    British44192900001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    BURGAN, Lynne Frances
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish3311690001
    BURGAN, Philip John
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish2140090001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Director
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    British43835770003
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Director
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Director
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Director
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman220582440001
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Director
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Director
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    MUSER, Dominik
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Director
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    GermanyGerman295759150001
    PRIDMORE, Richard
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    Director
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish39535850001
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    ROCHE, Patrick Joseph
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish126410600001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Director
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish980530001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Director
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Director
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandBritish299860960001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RUBY DCO TEN LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Dunamis Mind Accelerator Limited
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    31 ago 2023
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 abr 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroGreat Britain
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro244282
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene RUBY DCO TEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 17 oct 1994
    Entregado el 18 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-goldwick pharmacy glodwick health centre goldwick road, oldham including all guarantees and covenats now or in the future subsisting in respect of the property and the benefit of all insurance policies all moneys and proceeds paid or payable inrespect of the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 18 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 29 jul 1994
    Entregado el 30 jul 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Breve descripción
    F/H-459 great horton road bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 30 jul 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 13 jun 1994
    Entregado el 18 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    First charge on all stock shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions in respect of the same and all allotments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 18 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 13 jun 1994
    Entregado el 18 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Breve descripción
    L/H-ground floor premises 280-282 lees road oldham lancs. Floating charge over all tha moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 18 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 may 1994
    Entregado el 25 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-34 nostell place bessacarr doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 25 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 may 1994
    Entregado el 25 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-the pharmacy sinclair house woodside view the crescent woodlands doncster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 25 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 may 1994
    Entregado el 25 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-2 princess street woodlands doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 25 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 may 1994
    Entregado el 25 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H- the pharmacy land and buildings on the east side of adwick road mexborough doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 25 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 may 1994
    Entregado el 20 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-6 york bar york road doncaster. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 20 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 03 may 1994
    Entregado el 09 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-the pharmacy new street dinnington rotherham south yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 09 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 04 mar 1994
    Entregado el 14 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-pharmacy at the new health centre cluntergate horbury wakefield west yorkshire t/n-WYK542628, WTK459121 and WYK55116 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 feb 1994
    Entregado el 04 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Breve descripción
    First fixed charge on all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions paid or payable or made in respect of the same and allotments accreations offers rights benefits and advantages on all stocks shares rights money or property accruing or offered at any time by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 04 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 31 ene 1994
    Entregado el 01 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or this mortgage
    Breve descripción
    L/H-48 cheapside barnsley south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 01 feb 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 24 ene 1994
    Entregado el 26 ene 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or under the terms of the debenture and security
    Breve descripción
    L/H-3A far lane wadsley and land on the south side of wadsley lane and land on the N.E. of far lane sheffield t/n-SYK210526 and SYK313104. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 26 ene 1994Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 13 dic 1993
    Entregado el 18 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this mortgage
    Breve descripción
    L/H-the pharmacy minden centre st.johns garden the rock bury t/n-GM633326. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finanace Limited
    Transacciones
    • 18 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 13 dic 1993
    Entregado el 18 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Breve descripción
    L/H-unit 3 ribblesdale house market street bury t/n-GM512146. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finanace Limited
    Transacciones
    • 18 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 06 sept 1993
    Entregado el 14 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee
    Breve descripción
    F/H-86 burgoyne road sheffield t/n-SYK113360. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 14 sept 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 05 jul 1993
    Entregado el 07 jul 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage
    Breve descripción
    L/H-13 halifax road dewsbury west yorkshire and stock-in-trade. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transacciones
    • 07 jul 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 01 jun 1993
    Entregado el 07 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-50-52 high street idle bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 07 jun 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 01 abr 1993
    Entregado el 06 abr 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: 21 and 21A chapeltown pudsey leeds west yorkshire t/n-WYK24687. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 06 abr 1993Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 mar 1993
    Entregado el 08 mar 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details see form 395 and contd sheets attached). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 08 mar 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 feb 1993
    Entregado el 04 feb 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 04 feb 1993Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 22 sept 1992
    Entregado el 07 oct 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H-26 main street garforth leeds west yorshire (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 07 oct 1992Registro de un cargo (395)
    • 22 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 jun 1992
    Entregado el 05 jun 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 05 jun 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 abr 1992
    Entregado el 22 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details of property see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Statim Finance Limited
    Transacciones
    • 22 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 25 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0