STAGECOACH WEST LIMITED

STAGECOACH WEST LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTAGECOACH WEST LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02041677
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STAGECOACH WEST LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra STAGECOACH WEST LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STAGECOACH WEST LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WESTERN TRAVEL LIMITED20 oct 198620 oct 1986
    EXPELOAK LIMITED29 jul 198629 jul 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STAGECOACH WEST LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STAGECOACH WEST LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 may 2013

    Estado de capital el 07 may 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Leslie Brian Warneford como director el 26 abr 2013

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 04 mar 2013

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Ian Roy Manning como director el 21 feb 2013

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2011

    14 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    7 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2010

    14 páginasAA

    Cambio de datos del director Ian Roy Manning el 11 may 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Michael John Vaux el 10 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 abr 2009

    13 páginasAA

    Cambio de datos del director Leslie Brian Warneford el 01 nov 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Colin Brown el 15 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Michael John Vaux el 07 oct 2009

    1 páginasCH03

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de STAGECOACH WEST LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Secretario
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Secretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    HEMMING, Christopher Thomas
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    British17902220001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Secretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    CARTER, Alex Paul
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    Director
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    British41601830001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Director
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Director
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Director
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Director
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    DYER, Andrew William
    10 Saxholm Way
    SO16 7GU Southampton
    Director
    10 Saxholm Way
    SO16 7GU Southampton
    British62948690001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Director
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Director
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Director
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HILDITCH, Christopher Graham
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    Director
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    British10417870001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Director
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    HIRON, William
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15390480001
    IRVING, Charles, Sir
    The Grange
    GL50 2JH Cheltenham
    Glos
    Director
    The Grange
    GL50 2JH Cheltenham
    Glos
    British31938710001
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Director
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LYON, Inglis
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    British72280120001
    MANNING, Ian Roy
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish90558800001
    RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    British5652350001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Director
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Director
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Director
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    STOCKLEY, Philip John
    Flat 31 Sirocco
    33 Channel Way
    SO14 3JE Southampton
    Hampshire
    Director
    Flat 31 Sirocco
    33 Channel Way
    SO14 3JE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish125533810001
    SUTTON, Martin
    44 Chandos Street
    Winchcombe
    GL54 5HX Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    44 Chandos Street
    Winchcombe
    GL54 5HX Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish54001710002
    THOMAS, Mark Richard
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Director
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British28914510001
    THOMAS, Norrie Russell
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish1447710001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Director
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    WHITE, Robert Neil Pratt
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    Director
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    British20722660001
    WILLIAMS, Paul Raymond
    Lane House
    Quarry Place
    SY1 1JN Shrewsbury
    Salop
    Director
    Lane House
    Quarry Place
    SY1 1JN Shrewsbury
    Salop
    United KingdomBritish8407960003

    ¿Tiene STAGECOACH WEST LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 30 sept 1996
    Entregado el 12 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under the agreement and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without prejudice to the foregoing generality, all obligations to indemnify the chargee (the "secured liabilities") provided that the expression secured liabilites shall not include any relevant liabilities of the company
    Breve descripción
    (1) as security for the payment of all secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges in favour of the chargee for itself and as agent and security trustee aforesaid by way of floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Agent and Security Trustee for and on Behalf of the Banks, the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transacciones
    • 12 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at gloucester road lansdown ind est cheltenham gloucs, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot canal road cwmbach aberdare mid glamorgan all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot lake road brynmawr gwent all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot risca road crosskeys newport gwent all buildings and other structures, any goodwill, plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot somerset road st. David's road cwmbran gwent, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot unit 20 merthyr tydfil ind est dowlais merthyr tydfil mid glamorgan, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery etc, floating charge all unattached plant machinery chattels goods. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 02 feb 1996
    Entregado el 17 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto
    Breve descripción
    By way of floating charge all its undertaking property assets and rights present and future.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Security Trustee for and on Behalf of the Banks the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transacciones
    • 17 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at eastcott road swindon wilts.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at station approach leamington spa warwickshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at new town road warwickshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at railway terrace rugby warwickshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at london road gloucester.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Premises at london road bowbridge stroud gloucestershire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 jun 1995
    Entregado el 02 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Bus depot at canal street banbury oxfordshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jun 1995Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 dic 1993
    Entregado el 18 dic 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as western travel limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 dic 1993Registro de un cargo (395)
    • 15 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 abr 1992
    Entregado el 12 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Please see doc M436C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 may 1992Registro de un cargo (395)
    • 14 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 oct 1986
    Entregado el 10 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a share purchase agreement of even date.
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Bus Company
    Transacciones
    • 10 nov 1986Registro de una carga
    Mortgage debenture
    Creado el 31 oct 1986
    Entregado el 07 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Charge by way of specific equitable charge over all estates and/or interest of f/h & l/h property flowing charge over over taking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. (For full details see form 395).
    Personas con derecho
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transacciones
    • 07 nov 1986Registro de una carga
    • 21 dic 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0