IP2IPO INNOVATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IP2IPO INNOVATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02060639 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2nd Floor 3 Pancras Square Kings Cross N1C 4AG London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| IMPERIAL INNOVATIONS LIMITED | 28 dic 2005 | 28 dic 2005 |
| IMPERIAL COLLEGE INNOVATIONS LIMITED | 25 mar 1998 | 25 mar 1998 |
| IMPERIAL EXPLOITATION LIMITED | 18 nov 1986 | 18 nov 1986 |
| TAKESHAKE LIMITED | 02 oct 1986 | 02 oct 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 10 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 24 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 10 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024 | 25 páginas | AA | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Windsor House Cornwall Road Harrogate HG1 2PW England a 2nd Floor 3 Pancras Square Kings Cross London N1C 4AG | 1 páginas | AD02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del secretario Ip2Ipo Services Limited el 27 mar 2025 | 1 páginas | CH04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 18 páginas | AA | ||
Modification des détails de Touchstone Innovations Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 dic 2019 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 2nd Floor 3 Pancras Square Kings Cross London N1C 4AG | 1 páginas | AD04 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 22 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Christopher Edward Glasson el 01 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Gregory Simon Smith el 01 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Ip2Ipo Services Limited el 01 dic 2021 | 1 páginas | CH04 | ||
Modification des détails de Touchstone Innovations Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 3 Pancras Square Pancras Square London N1C 4AG England a 2nd Floor 3 Pancras Square Kings Cross London N1C 4AG el 01 dic 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Top Floor, the Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF England a 3 Pancras Square Pancras Square London N1C 4AG el 01 dic 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Charles Nettleton Townend como director el 08 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Angela Leach como director el 12 may 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 20 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 22 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Christopher Edward Glasson como director el 26 mar 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP2IPO SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 3 Pancras Square N1C 4AG London 2nd Floor England |
| 122951520001 | ||||||||||
| BAYNES, David Graham | Director | 3 Pancras Square Kings Cross N1C 4AG London 2nd Floor England | United Kingdom | British | 177146390001 | |||||||||
| GLASSON, Christopher Edward | Director | 3 Pancras Square Kings Cross N1C 4AG London 2nd Floor England | United Kingdom | British | 195503590001 | |||||||||
| LEACH, Angela | Director | 3 Pancras Square Kings Cross N1C 4AG London 2nd Floor England | England | English | 154817250001 | |||||||||
| SMITH, Gregory Simon | Director | 3 Pancras Square Kings Cross N1C 4AG London 2nd Floor England | England | British | 241583760001 | |||||||||
| BOWEN, Justin | Secretario | Imperial Innovations Imperial College Exhibition Road SW7 2AZ London | British | 62530680003 | ||||||||||
| DOCX, Paul Francis | Secretario | 19 Ridgway Wimbledon SW19 4SN London | British | 6921210001 | ||||||||||
| JACOBS, Susan Lucy | Secretario | 184 Chiswick Village W4 3DG London | British | 15102960001 | ||||||||||
| RAYNER, William Nicholas | Secretario | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | 186575060001 | |||||||||||
| ANDERSON & COMPANY | Secretario corporativo | 76 Wallingford Road Shillingford OX10 7EU Wallingford Oxfordshire | 69872380001 | |||||||||||
| AHMAD, Anjum Mazahar | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | England | British | 142374710001 | |||||||||
| ARCHER, John Stuart, Professor | Director | Tall Trees Kinghorn Lane SL6 7QG Maidenhead Berkshire | British | 53409250001 | ||||||||||
| ATHERTON, Paul David, Dr | Director | Imperial Innovations Imperial College Exhibition Road SW7 2AZ London | United Kingdom | British | 87912060002 | |||||||||
| AUBREY, Alan John | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | United Kingdom | British | 77053350002 | |||||||||
| BANKS, William Lawrence | Director | Ridgebourne HR5 3EG Kington Herefordshire | United Kingdom | British | 36083600002 | |||||||||
| BAXENDELL, Peter Brian, Sir | Director | C/O The Shell Centre SE1 7NA London | British | 14133260001 | ||||||||||
| BIRLEY/NORBURN, Susan, Professor | Director | 10 Ripplevale Grove N1 1HU London | British | 54376110001 | ||||||||||
| CALDWELL, John, Professor | Director | Imperial College School Of Medicine Norfolk Place W2 1PG London | British | 56158150004 | ||||||||||
| CASTLE, Beryl Nelley Henriette | Director | Glebe House Ravenstone MK46 5AR Olney Buckinghamshire | British | 47731170001 | ||||||||||
| CLARK, Timothy John Hayes, Professor | Director | 8 Lawrence Court Mill Hill NW7 3QP London | England | British | 9547610001 | |||||||||
| CROSS, Neil Earl, Dr | Director | Sycamore House High Street Bluntisham PE17 3LA Huntingdon Cambridgeshire | British | 7308500001 | ||||||||||
| CUMMINGS, Russell | Director | Imperial Innovations Imperial College Exhibition Road SW7 2AZ London | United Kingdom | British | 119607580001 | |||||||||
| DESFORGES, Charles Desmond, Dr | Director | High Trees Templewood Lane Stoke Poges SL2 3HW Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 32911030001 | |||||||||
| GEE, Charles Jonathan, Dr | Director | 47 Princes Gate SW7 2QA London | British | 74831110004 | ||||||||||
| GRAVES, Brian Clive | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | United Kingdom | British | 142373400001 | |||||||||
| HANSEN, Michael Ray | Director | 11 Gentlemans Row EN2 6PT Enfield | England | British | 39219480001 | |||||||||
| HICKSON, Anthony Charles | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | United Kingdom | British | 174597870001 | |||||||||
| KNIGHT, Martin Peter, Dr | Director | Imperial Innovations Imperial College Exhibition Road SW7 2AZ London | England | British | 64447520004 | |||||||||
| MACARTHUR, John Peter | Director | Mill House Mill Lane Dedham CO7 6DH Colchester Essex | United Kingdom | British | 5953680001 | |||||||||
| MAINI, Tidu, Dr | Director | Imperial College Administration Imperial College SW7 2AZ London | British | 126434470001 | ||||||||||
| PERRY, Roderick William | Director | 15 Milverton Terrace CV32 5BE Leamington Spa Warwickshire | British | 30236430001 | ||||||||||
| PINDORIA, Govind Keshavji | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | England | British | 131821370001 | |||||||||
| PITCHFORD, Nigel Aaron | Director | 25 Walbrook EC4N 8AF London Top Floor, The Walbrook Building England | United Kingdom | British | 166776340001 | |||||||||
| ROWAN, Mark Derrick Ranulph | Director | 4 Dominus Way LE19 1RP Leicester Leicestershire | England | British | 79364280002 | |||||||||
| SEARLE, Susan Jane | Director | Imperial Innovations Imperial College Exhibition Road SW7 2AZ London | England | British | 65252480003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IP2IPO INNOVATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Innovations Limited | 06 abr 2016 | Pancras Square N1C 4AG London 2 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0