BROADGATE EXCHANGE SQUARE
Visión general
| Nombre de la empresa | BROADGATE EXCHANGE SQUARE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 02060949 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BROADGATE EXCHANGE SQUARE LIMITED | 08 dic 1987 | 08 dic 1987 |
| ALPHAFORM (NO.28) PUBLIC LIMITED COMPANY | 02 oct 1986 | 02 oct 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Bruce Michael James como director el 10 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Michael John Forshaw como director el 05 abr 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Charles Mcnuff como director el 03 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Charles John Middleton como director el 03 abr 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ndiana Ekpo como secretario el 06 dic 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de British Land Company Secretarial Limited como secretario | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Nombramiento de British Land Company Secretarial Limited como secretario el 06 dic 2016 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Secretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Secretario | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | British | 1898090001 | ||||||||||
| HALLAM, Jonathan Paul | Secretario | 11 Trinity Road SW19 8QT London | British | 36631180001 | ||||||||||
| HUGHES, Paul | Secretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| ADAM, Shenol | Director | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BATES, Nicholas Keith | Director | 77 South View Avenue Caversham RG4 5AJ Reading Berkshire | British | 58257980001 | ||||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BERRY, David Charles | Director | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 166550001 | ||||||||||
| BLACKBURN, David Michael | Director | Lansdowne Road W11 3AL London 7 | England | British | 67601540001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRADMAN, Godfrey Michael | Director | 15 Hanover Terrace NW1 4RJ London | British | 2068500001 | ||||||||||
| CAMP, David John | Director | 11 Walham Grove SW6 London | British | 4807190002 | ||||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| DANTZIC, Roy Matthew | Director | 65 Springfield Road St Johns Wood NW8 0QJ London | British | 52294450003 | ||||||||||
| DOYLE, Eugene Francis | Director | 2 Gombards AL3 5NW St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | 73961570001 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| HALLAM, Jonathan Paul | Director | 11 Trinity Road SW19 8QT London | British | 36631180001 | ||||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| KALMAN, Stephen Lionel | Director | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | 1188110001 | |||||||||
| KERSHAW, Peter | Director | 34 Esher Park Avenue KT10 9NX Esher Surrey | British | 51322410001 | ||||||||||
| LIPTON, Stuart Anthony, Sir | Director | 40 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | 2068540001 | |||||||||
| MANNION, Michael John Francis | Director | 32 Acacia Way The Hollies DA15 8WW Sidcup Kent | United Kingdom | British | 57126040001 | |||||||||
| MORKEL, Alan Gaunson | Director | Bramble Cottage 1 Churn Lane Horsmonden TN12 8HL Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 2068470001 | |||||||||
| RITBLAT, John, Sir | Director | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | 41694870001 | |||||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Director | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||||||
| RIVLIN, Paul Denis | Director | 42 Rochester Road NW1 9JJ London | British | 2068550001 | ||||||||||
| ROBERTS, Graham Charles | Director | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BROADGATE EXCHANGE SQUARE?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadgate Investment Holdings Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BROADGATE EXCHANGE SQUARE alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Creado el 23 nov 1992 Entregado el 01 dic 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the override agreement dated 23 november 1992 and this charge | |
Breve descripción See form 395 ref M93 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0