INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED

INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTERCAPITAL NO. 3 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02062368
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo al transporte (52290) / Transporte y almacenamiento

    ¿Dónde se encuentra INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ICAP SHIPPING LIMITED31 jul 200831 jul 2008
    ICAP HYDE & COMPANY LIMITED03 may 200703 may 2007
    J.E. HYDE & CO. LIMITED08 ene 198708 ene 1987
    OPENSTATIC LIMITED08 oct 198608 oct 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Cese del nombramiento de Veronica Holly Ridley como secretario el 01 jul 2021

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Richard Joseph Bodnum el 02 nov 2020

    2 páginasCH01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada London Fruit and Wool Exchange 1 Duval Square London E1 6PW

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a London Fruit and Wool Exchange 1 Duval Square London E1 6PW

    2 páginasAD02

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Domicilio social registrado cambiado de London Fruit and Wool Exchange 1 Duval Square London E1 6PW England a 1 More London Place London SE1 2AF el 26 mar 2021

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 mar 2021

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2021 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Richard Joseph Bodnum como director el 28 ene 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kathleen Marie Cronin como director el 28 ene 2021

    1 páginasTM01

    Notification de Intercapital Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov 2020

    2 páginasPSC02

    Cessation de Intercapital No. 1 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 nov 2020

    1 páginasPSC07

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 19 oct 2020

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share prem a/c 09/10/2020
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 jul 2020

    • Capital: GBP 33,352,400
    3 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 jul 2020

    • Capital: GBP 21,556,400
    3 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 16 jul 2020

    • Capital: GBP 19,496,400
    3 páginasSH01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Veronica Holly Ridley como secretario el 14 ene 2020

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KNOTTENBELT, William Frederick
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish133292870001
    SEAMAN, Adrienne Hilary
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish260951030001
    ABREHART, Deborah Anne
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    Secretario
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    230113660001
    CAVANAGH, Teri-Anne
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Secretario
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    South African98738710013
    GROVE, William Hulbert
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    Secretario
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    British73604420001
    MURRAY, Shona
    55 Dorchester Avenue
    HA2 7AX Harrow
    Middlesex
    Secretario
    55 Dorchester Avenue
    HA2 7AX Harrow
    Middlesex
    British71311260001
    RIDLEY, Veronica Holly
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Secretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    266572370001
    WEBSTER, Peter James
    13 Calverton
    Albany Road
    SE5 0AP London
    Secretario
    13 Calverton
    Albany Road
    SE5 0AP London
    British50014310003
    WHITWELL, John Gordon Robson
    24 Military Road
    CO1 2AJ Colchester
    Essex
    Secretario
    24 Military Road
    CO1 2AJ Colchester
    Essex
    British65531480001
    AHRENS, Christopher Robert
    Bothy Cottage
    2 Plaw Hatch Lane
    RH19 4JL Sharpthorne
    Director
    Bothy Cottage
    2 Plaw Hatch Lane
    RH19 4JL Sharpthorne
    British74062450002
    BARCLAY, Lorraine Emma
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    Director
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    EnglandBritish156498490001
    BODNUM, Richard Joseph
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    Director
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    United StatesAmerican261217990002
    CASTERTON, David Anthony
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    United KingdomBritish221477890001
    CRONIN, Kathleen Marie
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    Director
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    United StatesAmerican156507760001
    DARGAN, Nicholas James
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    Director
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    EnglandBritish298810620001
    EWER, Michael David
    Pampas
    High Molewood
    SG14 2PL Hertford
    Director
    Pampas
    High Molewood
    SG14 2PL Hertford
    British24093950003
    GORDON CLARK, Edmund Francis
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    United KingdomBritish106715260001
    GROVE, William Hulbert
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    Director
    Spring Close
    Millers Lane, Outwood
    RH1 5PZ Redhill
    Surrey
    EnglandBritish73604420001
    HAMILTON, David Douglas
    76 Hoylake Crescent
    Ickenham
    UB10 8JF Uxbridge
    Middlesex
    Director
    76 Hoylake Crescent
    Ickenham
    UB10 8JF Uxbridge
    Middlesex
    British42633620001
    HARDING, Peter Leslie
    Martlets Greenways
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7QE Tadworth
    Surrey
    Director
    Martlets Greenways
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7QE Tadworth
    Surrey
    British8897950001
    HARRISON, Simon Nicholas Ian
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish59864540003
    HEAL, Victor
    5 The Sycamores
    BN6 9XP Sayers Common
    West Sussex
    Director
    5 The Sycamores
    BN6 9XP Sayers Common
    West Sussex
    British124656690001
    HOLLYER, Nigel
    5 Gregory Avenue
    Pondwell
    PO33 1PZ Ryde
    Isle Of Wight
    Director
    5 Gregory Avenue
    Pondwell
    PO33 1PZ Ryde
    Isle Of Wight
    British65676500003
    JUNCHER, Jacob
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Danish93424280001
    KIDD, Timothy Charles
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish117842820001
    LATAWIEC, Jerzy Maksymilian
    27 Sunny Bank
    Widmer End
    HP15 6PA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    27 Sunny Bank
    Widmer End
    HP15 6PA High Wycombe
    Buckinghamshire
    British27419550001
    LEE, Carlton Millhouse
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Director
    Bankside The Close
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    British36055910001
    LIDDELL, Henry Grainger
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    Director
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    United KingdomBritish34376200006
    MATHEWS, Robert Malcolm
    12 Augustas Way
    CM8 1HH Witham
    Essex
    Director
    12 Augustas Way
    CM8 1HH Witham
    Essex
    British35862010001
    MAYHEW, Lucy Rachel
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish151929170002
    MCDONALD, Bruce William
    14 Saxonbury Close
    TN6 1EA Crowborough
    East Sussex
    Director
    14 Saxonbury Close
    TN6 1EA Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish27419570001
    NEWMAN, Paul
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    Director
    2 Broadgate
    London
    EC2M 7UR
    EnglandBritish213629960001
    NEWMAN, Paul
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    EnglandBritish213629960001
    OVERALL, Paul David
    20 Crowborough Road
    SS2 6LP Southend On Sea
    Essex
    Director
    20 Crowborough Road
    SS2 6LP Southend On Sea
    Essex
    British12128420001
    PARSBO, Christian Heerdegen
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Director
    Broadgate
    2 Broadgate
    EC2M 7UR London
    2
    England
    Danish121505700001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    11 nov 2020
    1 Duval Square
    E1 6PW London
    London Fruit And Wool Exchange
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01423001
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Intercapital No. 1 Limited
    EC2M 7UR London
    2 Broadgate
    England
    06 abr 2016
    EC2M 7UR London
    2 Broadgate
    England
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro6173794
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 09 oct 2000
    Entregado el 20 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 17 oct 1996
    Entregado el 24 oct 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 oct 1996Registro de un cargo (395)
    • 22 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creado el 10 nov 1993
    Entregado el 12 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The sum of £65,000 credited to account no. 91002771 with the bank together with all sums credited to that account and including all interest accruing thereon.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 28 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene INTERCAPITAL NO. 3 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 mar 2021Inicio de la liquidación
    19 jun 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Profesional
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Profesional
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0