ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02077545 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2-3 Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton East Sussex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ROCKYWOOD LIMITED | 26 nov 1986 | 26 nov 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 15 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Arcadis House, 34 York Way London N1 9AB a 2-3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE el 16 abr 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Geoffrey Brookes como director el 21 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Allan Cowlard como director el 21 mar 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keith Lawrence Brooks como director el 29 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Anne Rosemary Clark como director el 01 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Echq 34 York Way London N1 9AB a Arcadis House, 34 York Way London N1 9AB el 12 nov 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Anthony Youell como director el 01 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Keith Lawrence Brooks como director el 01 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Vincent Madden como director el 01 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alan Geoffrey Brookes como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNCOMBE, Fiona Margaret | Secretario | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | 174676320001 | |||||||
| CLARK, Anne Rosemary | Director | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 152529010001 | |||||
| COWLARD, Mark Allan | Director | N1 9AB London Arcadis House 34 York Way England | England | British | 244447190001 | |||||
| MADDEN, Peter Vincent | Director | Pavilion Buildings BN1 1EE Brighton 2-3 East Sussex | England | British | 138480270002 | |||||
| DIXON, Peter Rae | Secretario | The Manor House Rowberrow BS25 1QL Winscombe Somerset | British | 1725240003 | ||||||
| EAKINS, Simon Mark | Secretario | 4 Seymour Avenue BS7 9HJ Bristol Avon | British | 116842500001 | ||||||
| HUDSON, Peter Evason | Secretario | 37b Heathfield Road Wandsworth SW18 2PH London | British | 17157210003 | ||||||
| MCLEOD, Alasdair Simpson | Secretario | 47 Salisbury Road Redland BS6 7AR Bristol | British | 70306040002 | ||||||
| SMITH, Andrew Peter | Secretario | 34 York Way N1 9AB London Echq United Kingdom | British | 126244190001 | ||||||
| ARNOLD, Leonard John Duncan | Director | Midway Lady Margaret Road Sunningdale SL5 9QL Ascot Berkshire | Gbr | British | 17785780001 | |||||
| BARRETT, Darren Roy | Director | Furnival Street EC4A 1YH London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 161834400001 | |||||
| BARTLETT, Jeremy | Director | 37 Wood Road Codsall WV8 1DN Wolverhampton Staffordshire | British | 39570000001 | ||||||
| BROOKES, Alan Geoffrey | Director | York Way N1 9AB London Arcadis House, 34 England | England | British | 141385140004 | |||||
| BROOKS, Keith Lawrence | Director | York Way N1 9AB London Arcadis House, 34 England | England | British | 174928960001 | |||||
| CALVER, Graham John | Director | Nielpahar GL15 6UU Hewelsfield Gloucestershire | United Kingdom | British | 1725260001 | |||||
| CARROLL, Michael Dennis | Director | Furnival Street EC4A 1YH London 10 United Kingdom | United Kingdom | American | 159854620002 | |||||
| GOODBODY, Edward Arthur | Director | Stockmans Rectory Hill HP7 0BT Amersham Buckinghamshire | British | 2030040002 | ||||||
| GOUDIE, Kenneth Patterson | Director | Furnival Street EC4A 1YH London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 60131520002 | |||||
| HARVEY, John | Director | 5 Rudd Hall Rise GU15 2JZ Camberley Surrey | British | 39570150001 | ||||||
| KAKUMOTO, Takashi | Director | 9 Queens Drive Acton W3 0HF London | Japanese | 52239270001 | ||||||
| MATSUMOTO, Yoshio | Director | 4-9-18-707 Kitashinjuku Shinjuku-Ku Tokyo Japan | Japanese | 50025690001 | ||||||
| MCGAHEY, Andrew Michael John | Director | Michaelhouse 2 Millington Road CB3 9HP Cambridge | England | British | 82253710001 | |||||
| NEAL, Timothy | Director | 34 York Way N1 9AB London Echq United Kingdom | England | British | 134660430001 | |||||
| ODONNELL, Noel Joseph | Director | Furnival Street EC4A 1YH London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 27814200002 | |||||
| PORTER, Stephen Thomas | Director | 22 Church Road SG14 3DP Hertford Hertfordshire | British | 30559200001 | ||||||
| SHIBATA, Masatoshi | Director | Grove House 25 Pine Grove N20 8LB London | Japanese | 2936140001 | ||||||
| SMITH, Andrew Peter | Director | 34 York Way N1 9AB London Echq United Kingdom | England | British | 126244190002 | |||||
| SMITH, Antony Panayiotis | Director | Somerset House 18 Canynge Road BS8 3JX Clifton Bristol | United Kingdom | British | 11769910002 | |||||
| SOGA, Akihiko | Director | Tudor Heights Chislehurst Road BR7 5LD Chislehurst Kent | Japanese | 44308740001 | ||||||
| SYKES, Anthony Peter Mark | Director | Somerset House 18 Canynge Road BS8 3JX Clifton Bristol | United Kingdom | British | 27814190002 | |||||
| TAYLOR, Brian Ross | Director | Somerset House 18 Canynge Road BS8 3JX Clifton Bristol | United Kingdom | British | 169229740001 | |||||
| TORIKAI, Kazutoshi | Director | 606-1-2603 Kamitsuruma Sagamihara-City FOREIGN Kanagawa Prefecture Japan | Japanese | 47488450001 | ||||||
| VINCE, Peter John | Director | Furnival Street EC4A 1YH London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 72493100004 | |||||
| WALLACE, Eric Thornton | Director | Tring House Bridgwater Road BS25 1NN Winscombe Somerset | England | British | 1888270001 | |||||
| WILDGOOSE, Ian | Director | 6 Flitch Lane CM6 1EL Great Dunmow Essex | British | 103180520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis Gulf Limited | 06 abr 2016 | York Way N1 9AB London Arcadis House, 34 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 07 ago 1998 Entregado el 17 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene ARNOLD PROJECT SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0