KESWICK HOLDINGS LIMITED

KESWICK HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKESWICK HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02078966
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KESWICK HOLDINGS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra KESWICK HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KESWICK HOLDINGS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2016
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2016
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KESWICK HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Alexander Edward Compton Hare como director el 05 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como secretario el 05 oct 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como director el 05 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2017 au 31 dic 2016

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 1

    3 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2016

    Estado de capital el 08 ene 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Maxwell David Shaw James como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Daniel Mark Greenslade como director el 31 mar 2015

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Sandra Judith Odell como director el 31 mar 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard James Stearn como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 ene 2015

    Estado de capital el 11 ene 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Maxwell David Shaw James el 04 ago 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Richard James Stearn el 10 sept 2014

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Sandra Judith Odell el 04 ago 2014

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 16 Grosvenor Street London W1K 4QF a 43-45 Portman Square London W1H 6LY el 05 ago 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    9 páginasAA

    Misceláneos

    Section 519
    4 páginasMISC

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 ene 2014

    Estado de capital el 07 ene 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de KESWICK HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HARE, Alexander Edward Compton
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish215786330001
    CAMPBELL, Rosemary Joy
    Rosebank 19 Orchard Rise
    Shirley
    CR0 7QZ Croydon
    Surrey
    Secretario
    Rosebank 19 Orchard Rise
    Shirley
    CR0 7QZ Croydon
    Surrey
    British13408960001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Secretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Secretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    GIBSON, Timothy David
    Flat 4 90/92 Seven Sisters Road
    N7 6AE London
    Secretario
    Flat 4 90/92 Seven Sisters Road
    N7 6AE London
    British50070710002
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Secretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Secretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175336300001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Secretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    ROBSON SKEETE, Gail
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    Secretario
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    British58498140001
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British39676720001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Secretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    CAMPBELL, Rosemary Joy
    Rosebank 19 Orchard Rise
    Shirley
    CR0 7QZ Croydon
    Surrey
    Director
    Rosebank 19 Orchard Rise
    Shirley
    CR0 7QZ Croydon
    Surrey
    British13408960001
    CLARK, James Robert
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    Director
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    United KingdomBritish52063220001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Director
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Director
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Director
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Director
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Director
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish164108510002
    LAZARUS, James Nicholas
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish8315580001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish132142980001
    PARRETT, Gary Douglas
    2 Ringmer Way
    BR1 2TY Bickley
    Kent
    Director
    2 Ringmer Way
    BR1 2TY Bickley
    Kent
    British71816830001
    PARRETT, Mark Stephen
    The Laurels Coopers Corner
    Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    Director
    The Laurels Coopers Corner
    Ide Hill
    TN14 6LB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish13853490001
    PARRETT, Turrloo Francis
    Letts Green Knockholt
    Shirley
    CR0 Croydon
    Surrey
    Director
    Letts Green Knockholt
    Shirley
    CR0 Croydon
    Surrey
    British31464880001
    PARRETT, Turrloo Francis
    Letts Green
    Knockholt
    TN14 7PG Sevenoaks
    Kent
    Director
    Letts Green
    Knockholt
    TN14 7PG Sevenoaks
    Kent
    British33840450001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Director
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Director
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Director
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British39676720001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Director
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Director
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish42858810002

    ¿Tiene KESWICK HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental deed of debenture
    Creado el 08 mar 1996
    Entregado el 22 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under the terms of the richard english agreement dated 19/2/96 will also be recured under the debenture dated 17/6/94 as amended by this supplemental deed of debenture dated 8/3/96
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 22 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 17 jun 1994
    Entregado el 23 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 23 jun 1994Registro de un cargo (395)
    • 25 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0