KESWICK HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KESWICK HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02078966 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KESWICK HOLDINGS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 43-45 Portman Square W1H 6LY London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2016 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2016 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Alexander Edward Compton Hare como director el 05 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como secretario el 05 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como director el 05 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2017 au 31 dic 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 3 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Maxwell David Shaw James como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Mark Greenslade como director el 31 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Sandra Judith Odell como director el 31 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard James Stearn como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Maxwell David Shaw James el 04 ago 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Richard James Stearn el 10 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Sandra Judith Odell el 04 ago 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 16 Grosvenor Street London W1K 4QF a 43-45 Portman Square London W1H 6LY el 05 ago 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 4 páginas | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 13 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENSLADE, Daniel Mark | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HARE, Alexander Edward Compton | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 215786330001 | |||||
| CAMPBELL, Rosemary Joy | Secretario | Rosebank 19 Orchard Rise Shirley CR0 7QZ Croydon Surrey | British | 13408960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Secretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Secretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| GIBSON, Timothy David | Secretario | Flat 4 90/92 Seven Sisters Road N7 6AE London | British | 50070710002 | ||||||
| HUGHES, Paul | Secretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Secretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175336300001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Secretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Secretario | 17 Field Close Locks Heath SO31 6TX Southampton Hampshire | British | 58498140001 | ||||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Secretario | 2 Fernsleigh Close SL9 0HR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 39676720001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Secretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| CAMPBELL, Rosemary Joy | Director | Rosebank 19 Orchard Rise Shirley CR0 7QZ Croydon Surrey | British | 13408960001 | ||||||
| CLARK, James Robert | Director | Logmore 37 The Avenue SM2 7QA Cheam Surrey | United Kingdom | British | 52063220001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Director | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Director | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Director | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Director | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Director | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 164108510002 | |||||
| LAZARUS, James Nicholas | Director | Misbourne 47 Foxdell Way Chalfont St Peter SL9 0PL Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 8315580001 | |||||
| ODELL, Sandra Judith | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 132142980001 | |||||
| PARRETT, Gary Douglas | Director | 2 Ringmer Way BR1 2TY Bickley Kent | British | 71816830001 | ||||||
| PARRETT, Mark Stephen | Director | The Laurels Coopers Corner Ide Hill TN14 6LB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 13853490001 | |||||
| PARRETT, Turrloo Francis | Director | Letts Green Knockholt Shirley CR0 Croydon Surrey | British | 31464880001 | ||||||
| PARRETT, Turrloo Francis | Director | Letts Green Knockholt TN14 7PG Sevenoaks Kent | British | 33840450001 | ||||||
| RILEY, Michael Edward | Director | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Director | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Director | 2 Fernsleigh Close SL9 0HR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 39676720001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Director | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Director | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
¿Tiene KESWICK HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed of debenture | Creado el 08 mar 1996 Entregado el 22 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee arising under the terms of the richard english agreement dated 19/2/96 will also be recured under the debenture dated 17/6/94 as amended by this supplemental deed of debenture dated 8/3/96 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 17 jun 1994 Entregado el 23 jun 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0