NOVAE SYNDICATES LIMITED

NOVAE SYNDICATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNOVAE SYNDICATES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02082070
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SVB SYNDICATES LIMITED21 feb 199721 feb 1997
    SPRECKLEY VILLERS BURNHOPE & CO. LIMITED21 oct 199321 oct 1993
    SPRECKLEY VILLERS HUNT & CO. LIMITED09 dic 198609 dic 1986

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 sept 2020

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 sept 2020

    8 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 52 Lime Street London EC3M 7AF United Kingdom a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS el 09 oct 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 sept 2019

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Timothy Hennessy el 04 sept 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Fintan Mullarkey el 04 sept 2019

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Mark Keith Rowe como secretario el 28 ago 2019

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Kelly Lawrence como secretario el 28 ago 2019

    2 páginasAP03

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Novae Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 abr 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 21 Lombard Street London EC3V 9AH United Kingdom a 52 Lime Street London EC3M 7AF el 10 may 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    19 páginasAA

    Cese del nombramiento de Diane Fabienne Marie Cote como director el 31 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David John Pye como director el 31 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven Paul Burns como director el 31 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Martin Peter Hudson como director el 31 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas James Moss como director el 23 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Timothy Hennessy como director el 21 mar 2018

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LAWRENCE, Kelly
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Secretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    261862060001
    HENNESSY, Timothy Patrick
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    IrelandIrishCompany Director241268900001
    MULLARKEY, Fintan
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    IrelandIrishCompany Director244441940001
    BROWN, Alexander Johnston
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    Secretario
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    British2569760001
    FURMSTON, Teresa Jane
    Meadow Close
    KT10 0AY Esher
    21
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Meadow Close
    KT10 0AY Esher
    21
    Surrey
    United Kingdom
    159828800001
    HEMING, Stephen John
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Secretario
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    184934060001
    MOON, Alexandra Jayne
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Secretario
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    209627600001
    ROWE, Mark Keith
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Secretario
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    241245180001
    TURVEY, Mark John
    21 Pinfold Road
    SW16 2SL London
    Secretario
    21 Pinfold Road
    SW16 2SL London
    British64741750001
    WHITTAKER, Philip David
    Badgers End
    Hoe Lane Abridge
    RM4 1AU Romford
    Essex
    Secretario
    Badgers End
    Hoe Lane Abridge
    RM4 1AU Romford
    Essex
    BritishCompany Secretary22377940003
    WILLIS, Christopher James Percival
    Stickle Ghyll
    One Berry Close
    SS16 6BZ Langdon Hills
    Essex
    Secretario
    Stickle Ghyll
    One Berry Close
    SS16 6BZ Langdon Hills
    Essex
    British22377920001
    ADAMS, Jeremy Richard
    Graffham
    Petworth
    GU28 0NT West Sussex
    Eldridge House
    United Kingdom
    Director
    Graffham
    Petworth
    GU28 0NT West Sussex
    Eldridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritishRisk Director14939290004
    ADAMS, Laurence Philip
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector70191910001
    ADLAM, Lorraine Anne
    34 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    Director
    34 Ouseley Road
    SW12 8EF London
    BritishDirector34587930002
    BANSZKY, Caroline Janet
    6 Rylett Crescent
    W12 9RL London
    Director
    6 Rylett Crescent
    W12 9RL London
    EnglandBritishAccountant53649660002
    BOYNS, Jonathan Andrew
    100 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    Director
    100 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    BritishClaims Director84241020001
    BURFORD, Ian
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandBritishUnderwriter127687310002
    BURNHOPE, Stephen James
    Silwood
    Winkfield Road
    SL4 4BG Windsor
    Berkshire
    Director
    Silwood
    Winkfield Road
    SL4 4BG Windsor
    Berkshire
    BritishUnderwriter13302040003
    BURNS, Steven Paul
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director228248920002
    BUTCHER, Jonathan Louis James
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritishUnderwriter62273470001
    BUTCHER, Jonathan Louis James
    167 Wakehurst Road
    SW11 6BP London
    Director
    167 Wakehurst Road
    SW11 6BP London
    United KingdomBritishUnderwriter62273470001
    CARRINGTON, George Herbert
    42 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    Director
    42 Durham Avenue
    BR2 0QB Bromley
    Kent
    EnglandBritishUnderwriter50853160001
    CARSBERG, Bryan Victor, Sir
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant48800040001
    CLEGG, Simon John
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Director
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    BritishCompany Director61950010001
    CORBETT, Oliver Roebling Panton
    Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    6
    Director
    Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    6
    United KingdomBritishAccountant6062580002
    COTE, Diane
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandCanadianCompany Director156354840001
    DAVIS, William John
    38 Hornton Court
    Campden Hill Road
    W8 7RU London
    Director
    38 Hornton Court
    Campden Hill Road
    W8 7RU London
    UkBritishDirector53099700001
    ETTRIDGE, Peter John
    Highfield
    Lodge Lane
    CM3 6PW Purleigh
    Essex
    Director
    Highfield
    Lodge Lane
    CM3 6PW Purleigh
    Essex
    BritishLloyds Underwriter37227900002
    FORSTER, Robert Dennis
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    EnglandBritishMarine Underwriter163435710002
    HAMBRO, Anthony Everard George
    St. Georges Square
    SW1V 3QY London
    108
    Director
    St. Georges Square
    SW1V 3QY London
    108
    United KingdomBritishDirector24039390002
    HARRISON, David Bernard Kosta
    18 Edwardes Square
    W8 6HE London
    Director
    18 Edwardes Square
    W8 6HE London
    BritishChartered Accountant5981730001
    HEMING, Stephen John
    53 Hollingbourne Road
    SE24 9NB London
    Director
    53 Hollingbourne Road
    SE24 9NB London
    EnglandBritishCompliance Director95567250002
    HENDERSON, Robert David Charles
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    Director
    Lombard Street
    EC3V 9AH London
    21
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director43565270004
    HICKS, Alan David
    11 Maryland Road
    TN2 5HE Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    11 Maryland Road
    TN2 5HE Tunbridge Wells
    Kent
    BritishUnderwriter50853250001
    HIGGINS, David William
    Peverels Farm
    Colne Engaine
    CO6 2HS Colchester
    Essex
    Director
    Peverels Farm
    Colne Engaine
    CO6 2HS Colchester
    Essex
    BritishUnderwriter61452670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NOVAE SYNDICATES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Lime Street
    EC3M 7AF London
    52
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Lime Street
    EC3M 7AF London
    52
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2862216
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene NOVAE SYNDICATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 1998 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by the company to the bank under clause 2.1 of the deed of charge, and under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    All rights,title and interest of the company in and to the benefit of the specified syndicate reinsurances not otherwise expressed to be charged by this deed of charge or by any other document under which security is given by any person; the benefit of any letter of credit,guarantee,deposit or security issue; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 1998 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by each underwriting member of syndicate 1007 (a) on demand by the bank discharge in full to the bank when the same falls due each and every liability which the company have to the bank under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances (as defined) made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    First charge over all right,title and interest of the company in relation to all such calls pursuant to clause 15.14 (cash calls) of the facility agreement; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 1999 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by the company to the bank under clause 2.1 of the deed of charge, and under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    All rights,title and interest of the company in and to the benefit of the specified syndicate reinsurances not otherwise expressed to be charged by this deed of charge or by any other document under which security is given by any person; the benefit of any letter of credit,guarantee,deposit or security issue; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 1999 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by each underwriting member of syndicate 1007 (a) on demand by the bank discharge in full to the bank when the same falls due each and every liability which the company have to the bank under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances (as defined) made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    First charge over all right,title and interest of the company in relation to all such calls pursuant to clause 15.14 (cash calls) of the facility agreement; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 2000 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by the company to the bank under clause 2.1 of the deed of charge, and under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    All rights,title and interest of the company in and to the benefit of the specified syndicate reinsurances not otherwise expressed to be charged by this deed of charge or by any other document under which security is given by any person; the benefit of any letter of credit,guarantee,deposit or security issue; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 2000 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by each underwriting member of syndicate 1007 (a) on demand by the bank discharge in full to the bank when the same falls due each and every liability which the company have to the bank under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances (as defined) made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    First charge over all right,title and interest of the company in relation to all such calls pursuant to clause 15.14 (cash calls) of the facility agreement; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 2001 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by the company to the bank under clause 2.1 of the deed of charge, and under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    All rights,title and interest of the company in and to the benefit of the specified syndicate reinsurances not otherwise expressed to be charged by this deed of charge or by any other document under which security is given by any person; the benefit of any letter of credit,guarantee,deposit or security issue; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge in relation to the syndicate 1007 2001 dollar borrowing group (as defined)
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 10 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums and liabilities to be paid and discharged by each underwriting member of syndicate 1007 (a) on demand by the bank discharge in full to the bank when the same falls due each and every liability which the company have to the bank under or pursuant to the finance documents (as defined) including any liability in respect of any further overdraft advances (as defined) made under the facility agreement (as defined)
    Breve descripción
    First charge over all right,title and interest of the company in relation to all such calls pursuant to clause 15.14 (cash calls) of the facility agreement; see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 abr 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 13 ago 1992
    Entregado el 01 sept 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease dated 13 august 1992
    Breve descripción
    The sum of £70,000 initially deposited by spreckley villers hunt & co. Limited under the terms of the said rent deposit in a seperate designated deposit account in the name of the chargee and all monies subsequently in such account.
    Personas con derecho
    • Cheverell Estates Limited
    Transacciones
    • 01 sept 1992Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 sept 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit agreement
    Creado el 16 oct 1989
    Entregado el 20 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 22ND nov 1989 and this charge
    Breve descripción
    A rental deposit of £38,539.
    Personas con derecho
    • Anglo Soviet Shipping Co. Limited.
    Transacciones
    • 20 oct 1989Registro de una carga
    • 05 nov 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NOVAE SYNDICATES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 sept 2019Inicio de la liquidación
    30 dic 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0