AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02084205 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 80 Fenchurch Street EC3M 4AE London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CGNU COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | 04 jul 2000 | 04 jul 2000 |
| CGU COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | 23 jul 1998 | 23 jul 1998 |
| COMMERCIAL UNION COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | 09 jul 1990 | 09 jul 1990 |
| COMMERCIAL UNION (NO.12) LIMITED | 15 dic 1986 | 15 dic 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 17 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 31 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 17 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Ms Ramneet Kalsi como director el 14 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Rhona Helen Sim como director el 08 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Catriona Ann Fletcher como director el 14 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Carys Elizabeth Mccracken como director el 14 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Alix Clare Nicholson como director el 14 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Fraser William Easton como director el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Natasha Anne Twena como director el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 2 páginas | AA | ||
Nombramiento de James Wickham como director el 05 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Alice Parker Morgan como director el 05 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Gordon Paul Langley como director el 15 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Suzanna Louise Eyre como director el 09 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Fahrin Jivraj Ribeiro como director el 07 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Claire Elaine Phillips como director el 26 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Ms Emily Anne Field el 12 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Laura Eileen Mcgowan como director el 28 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Leena Ishavarlal Mistry como director el 30 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Victoria Louise De Temple como director el 11 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Undershaft Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mar 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 2 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Karina Jane Bye como director el 11 jul 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 17 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ a 80 Fenchurch Street London EC3M 4AE el 26 mar 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Ms Laura Eileen Mcgowan el 16 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD, Emily Anne | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 283015290002 | |||||
| FLETCHER, Catriona Ann | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 298350280001 | |||||
| KALSI, Ramneet | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 325487430001 | |||||
| KUCZYNSKA, Susan Margaret | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | England | British | 318161700001 | |||||
| MCCRACKEN, Carys Elizabeth | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 344474010001 | |||||
| MORGAN, Alice Parker | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 205629290001 | |||||
| NICHOLSON, Alix Clare | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 344474000001 | |||||
| PHILLIPS, Claire Elaine | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 332867650001 | |||||
| RIBEIRO, Fahrin Jivraj | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | England | British | 291830900001 | |||||
| SKELLERN, Nicholas James | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 109942180001 | |||||
| TWENA, Natasha Anne | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 340665200001 | |||||
| WICKHAM, James | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 338814900001 | |||||
| COOPER, Kirstine Ann | Secretario | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | British | 66125620003 | ||||||
| GRANT, Keith Nigel | Secretario | The Willows Pondtail Drive RH12 5HY Horsham West Sussex | British | 60473870001 | ||||||
| KUCZYNSKA, Susan Margaret | Secretario | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | 318611350001 | |||||||
| WHITAKER, Richard Andrew | Secretario | Strathblane Ashgrove Road TN13 1SS Sevenoaks Kent | British | 497250003 | ||||||
| ANSCOMBE, Michael John | Director | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | United Kingdom | British | 69734680001 | |||||
| BADDELEY, Julian Charles | Director | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | United Kingdom | British | 190030340002 | |||||
| BAILY, Kathryn Anna | Director | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | United Kingdom | British | 183686990001 | |||||
| BIRKS, Charlotte | Director | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helens England England | United Kingdom | British | 248082230001 | |||||
| BOURNER, Penelope Ellen Moira | Director | 30 Saint Peters Road West Mersea CO5 8LJ Colchester Essex | British | 63901950001 | ||||||
| BYE, Karina Jane | Director | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 239237640001 | |||||
| COMMONS, April Marie | Director | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | United Kingdom | British | 124541570001 | |||||
| COOPER, Kirstine Ann | Director | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | United Kingdom | British | 320134320001 | |||||
| COYLE, Ralph John | Director | Greenlands Manor Farm Court Guiseley LS20 9DT Leeds West Yorkshire | Great Britain | British | 85721810001 | |||||
| DE TEMPLE, Victoria Louise | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 287474690001 | |||||
| EASTON, Fraser William | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 268732270002 | |||||
| EATON, Angus Gordon | Director | 3 Pettwood Gardens Holbrook IP9 2WE Ipswich | United Kingdom | British | 114421690001 | |||||
| EATON, Angus Gordon | Director | Blickling House York Road, Skipwith YO8 5SF Selby North Yorkshire | British | 68819310003 | ||||||
| EYRE, Suzanna Louise | Director | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 308147760001 | |||||
| FENWICK, Graham Peter | Director | St Helen's 1 Undershaft EC3P 3DQ London | United Kingdom | British | 180617920001 | |||||
| GENIS, Ryan Burc, Mr | Director | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 261416040001 | |||||
| GRAHAM, Alexander Donald | Director | Lund Farm Main Street, Helperby YO61 2NT York North Yorkshire | British | 75015600001 | ||||||
| GRAHAM, Kate Louise | Director | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helens United Kingdom | United Kingdom | British | 107227940007 | |||||
| GRANT, Keith Nigel | Director | The Willows Pondtail Drive RH12 5HY Horsham West Sussex | British | 60473870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undershaft Limited | 06 abr 2016 | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0