HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02084578 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CHARTERHOUSE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED | 01 jun 1992 | 01 jun 1992 |
| CHARTERHOUSE PROPERTY SERVICES LIMITED | 20 feb 1987 | 20 feb 1987 |
| BROADSTENCE LIMITED | 17 dic 1986 | 17 dic 1986 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 16 may 2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Connelly Anderson como director el 19 ene 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David John Cavanna como director el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Romana Lewis como secretario el 13 ago 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hannah Elizabeth Shepherd como secretario el 13 ago 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Hannah Elizabeth Shepherd como secretario el 05 ene 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tony Bhambhra como secretario el 05 ene 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Tony Bhambhra como secretario el 13 ago 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katherine Dean como secretario el 13 ago 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de David John Cavanna como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Lyon como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Katherine Dean como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 mar 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Secretario | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 200248640001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| COLE, Richard John | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 32663530001 | |||||
| MARLOW, Jonathan Peter | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 159417990001 | |||||
| BHAMBHRA, Tony | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 190151450001 | |||||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Secretario | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
| DEAN, Katherine | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 177181780001 | |||||||
| JENKINSON, Louisa Jane | Secretario | Lindenwood Malacca Farm GU4 7UG West Clandon Surrey | British | 106060330003 | ||||||
| LYON, Karen | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 161199760001 | |||||||
| MILLER, Philip | Secretario | Sutton Court Fauconberg Road W4 3JF London 87 | Other | 128209650001 | ||||||
| OWEN, Stephen | Secretario | Clayton Croft Road Wilmington DA2 7AU Kent 11 United Kingdom | Other | 132334270001 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194218020001 | |||||||
| PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 1 Paternoster Row St Paul's EC4M 7DH London | 900015820001 | |||||||
| BOND, Iain Douglas | Director | 40 St Peters Square W6 9NR London | England | British | 68687180001 | |||||
| CAVANNA, David John | Director | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| DE ALBUQUERQUE, Simon Peter | Director | 15 Fielding Mews Barnes SW13 9EY London | England | British | 150525130001 | |||||
| DIX, Robert William | Director | Springfield The Ridge Woodcote Park KT18 7ET Epsom Surrey | British | 2067980005 | ||||||
| EDGCUMBE, John Charles | Director | 20 Charles Babbage Close KT9 2SA Chessington Surrey | British | 85343720002 | ||||||
| EVANS, Anthony John | Director | 55 Crown Street Redbourn AL3 7PF St Albans Hertfordshire | British | 21280530001 | ||||||
| GILL, Christopher Paul | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 43569560001 | |||||
| GLOVER, Edward Douglas | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 121380002 | |||||
| HUXTABLE, Christopher John | Director | The Cottage Golf Club Drive KT2 7DF Kingston Surrey | British | 50657810002 | ||||||
| IMPEY, Peter Henry | Director | Oak House Newick BN8 4SB Lewis East Sussex | United Kingdom | British | 88861820001 | |||||
| MACKEY, Paul Emmanuel | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 11264820014 | |||||
| MOFFAT, Andrew David John | Director | 6 Queen Annes Grove Ealing W5 3XR London | England | British | 34399870003 | |||||
| MOFFAT, Andrew David John | Director | 6 Queen Annes Grove Ealing W5 3XR London | England | British | 34399870003 | |||||
| PARISH, David William | Director | Michanda Spring Road Kinsbourne Green AL5 3PP Harpenden Hertfordshire | British | 2894070001 | ||||||
| RINGER, Simon David | Director | 115 Fawe Park Road SW15 2EG London | British | 52267810002 | ||||||
| SHORT, Jeanne Elizabeth | Director | Manor Cottage Speldhurst Road Langton Green TN3 0JL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 27753070001 | |||||
| TAYLOR, Christopher Mark | Director | 25 Felden Street Fulham SW6 5AE London | England | British | 159396060001 | |||||
| THORP, Timothy Geoffrey | Director | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | 66923730003 | |||||
| THORP, Timothy Geoffrey | Director | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | 66923730003 | |||||
| TSOUROUS, Lucy Anna | Director | 87 Elgin Mansions Elgin Avenue Maida Vale W9 1JN London | British | 63852340001 | ||||||
| VON GUIONNEAU, Werner Marc Friedrich | Director | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | England | German, | 110089200001 |
¿Tiene HSBC PROPERTY INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Third party charge of deposit account | Creado el 03 abr 1996 Entregado el 06 abr 1996 | Pendiente | Cantidad garantizada 50 per cent of (a) any quarterly amortisation amount payable by geranium properties limited or which geranium properties limited is bound to procure be paid into the escrow deposit account on each fixed portion interest payment date and which, at any relevant time has not been paid by geranium properties limited; and (b) the annual amortisation amount payable by geranium properties limited to wurttembergische hypothekenbank aktiengesellschaft on the second anniversary of the effective date (as defined in the facility agreement) and on each anniversary thereafter and which, at any relevant time has not been paid by geranium properties limited; in each case when and as the same shall become due in accordance with the terms and conditions of the facility agreement or in the case of (b) only on occurance of an event of default as defined in the facility agreement, if earlier. | |
Breve descripción All of the right title benefit and interest of the chargor in and to all monies standing from time to time to the credit of the deposit account of the chargor with the royal bank of scotland PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0