GREENBARR LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GREENBARR LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02090236 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GREENBARR LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra GREENBARR LIMITED?
| Dirección de la sede social | Micros Fidelio House 6-8 The Grove SL1 1QP Slough Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREENBARR LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED | 27 feb 1987 | 27 feb 1987 |
| VISUALANNUAL LIMITED | 16 ene 1987 | 16 ene 1987 |
| INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED | 16 ene 1987 | 16 ene 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENBARR LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GREENBARR LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENBARR LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2010 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Kaufman como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2009 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 04 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2008 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 353 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 190 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2007 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GREENBARR LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDER, Stephen | Secretario | The Old Brew House Brewery Common RG7 3JE Mortimer Berkshire | British | 41833080003 | ||||||
| NIROOMAND, Kaweh | Director | Salzach Strasse 55a FOREIGN 14129 Berlin Germany | Usa | Iranian | 119291160001 | |||||
| WALDER, Stephen | Director | The Old Brew House Brewery Common RG7 3JE Mortimer Berkshire | United Kingdom | British | 41833080003 | |||||
| WARD, Frank Peter | Director | 30 Bridle Road SL6 7RP Maidenhead Berkshire | United Kingdom | Irish | 118809190001 | |||||
| COSTER, Malcolm David | Secretario | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | 39034110001 | ||||||
| COTTRELL, Paul Alan | Secretario | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | 13754300002 | ||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Secretario | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
| GALL, Alan Farquhar | Secretario | 4 Wellesley Road TW2 5RS Twickenham Middlesex | British | 1728300001 | ||||||
| TAYLOR, David | Secretario | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| BAKER, Carl Howard | Director | The Croft Clews Lane GU24 9DZ Bisley Surrey | British | 58321590001 | ||||||
| BRADLEY, Michael John | Director | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | 40818740003 | ||||||
| COBY, Alan John | Director | Windermere Lodge Friday Street Pebworth CV37 8XW Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 50358320001 | ||||||
| COBY, Helen Mary | Director | The Plantation House Hotel Ermington PL21 9NS Ivybridge Devon | British | 80139540001 | ||||||
| CODGAN, James Raymond | Director | 32 King Edwards Road SL5 8NY Ascot Berkshire | British | 19597140001 | ||||||
| COSTER, Malcolm David | Director | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | 39034110001 | |||||
| EVANS, Robert Owen | Director | Hollybank 32 Birches Lane CV8 2AD Kenilworth Warwickshire | British | 57011000001 | ||||||
| GRAHAM, Ross King | Director | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||
| KAUFMAN, Gary | Director | 10203 Castehill Court Ellicott Md 21042 Usa | Usa | American | 118968570001 | |||||
| LOMAX, Christopher Morris David | Director | 4 Greenwood Road WA13 0LA Lymm Cheshire | British | 32315330001 | ||||||
| LOMAX, John Kevin | Director | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||
| MATTHEW, Gordon John | Director | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | 151547160001 | |||||
| NORTON, John Laurence | Director | 4 Waveney Close OX6 8GP Bicester Oxfordshire | British | 34339250001 | ||||||
| O'LEARY, Michael Kevin | Director | Greenwood Wichenford WR6 6YB Worcester Worcestershire | England | British | 129193560001 | |||||
| TAYLOR, David | Director | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Director | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | 76932830002 |
¿Tiene GREENBARR LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Credit agreement | Creado el 18 jul 1991 Entregado el 25 jul 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £53,003.16 due from the company to the chargee under the terms of the agreement. | |
Breve descripción All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Credit agreement | Creado el 13 mar 1991 Entregado el 20 mar 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £15949-24 due from the company under the terms of the agreement | |
Breve descripción All right, title and interest under the insurance. See form 395 (ref 495). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Credit agreement | Creado el 10 may 1990 Entregado el 22 may 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All its right title and interest in and to all sums payable under the insurances see form 395 (ref 136) for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 12 abr 1989 Entregado el 27 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Breve descripción All its right, title & interest in & to all sums payable (including by way of refund (under the insurances. As from time time varied or extended & the benfit of all powers & remedies for cancelling and/or enforcing the same. (For full details see form M395-M50C). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 10 mar 1987 Entregado el 17 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0