GREENBARR LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGREENBARR LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02090236
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GREENBARR LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GREENBARR LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Micros Fidelio House
    6-8 The Grove
    SL1 1QP Slough
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GREENBARR LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED27 feb 198727 feb 1987
    VISUALANNUAL LIMITED16 ene 198716 ene 1987
    INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED16 ene 198716 ene 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GREENBARR LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GREENBARR LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GREENBARR LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 dic 2013

    Estado de capital el 10 dic 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2010

    2 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Gary Kaufman como director

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2009

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2008

    3 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas190

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 jun 2007

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de GREENBARR LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WALDER, Stephen
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    Secretario
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    British41833080003
    NIROOMAND, Kaweh
    Salzach Strasse 55a
    FOREIGN 14129 Berlin
    Germany
    Director
    Salzach Strasse 55a
    FOREIGN 14129 Berlin
    Germany
    UsaIranian119291160001
    WALDER, Stephen
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    Director
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    United KingdomBritish41833080003
    WARD, Frank Peter
    30 Bridle Road
    SL6 7RP Maidenhead
    Berkshire
    Director
    30 Bridle Road
    SL6 7RP Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomIrish118809190001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Secretario
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    British39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Secretario
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    British13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GALL, Alan Farquhar
    4 Wellesley Road
    TW2 5RS Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    4 Wellesley Road
    TW2 5RS Twickenham
    Middlesex
    British1728300001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    BAKER, Carl Howard
    The Croft Clews Lane
    GU24 9DZ Bisley
    Surrey
    Director
    The Croft Clews Lane
    GU24 9DZ Bisley
    Surrey
    British58321590001
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Director
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    British40818740003
    COBY, Alan John
    Windermere Lodge Friday Street
    Pebworth
    CV37 8XW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Windermere Lodge Friday Street
    Pebworth
    CV37 8XW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British50358320001
    COBY, Helen Mary
    The Plantation House Hotel
    Ermington
    PL21 9NS Ivybridge
    Devon
    Director
    The Plantation House Hotel
    Ermington
    PL21 9NS Ivybridge
    Devon
    British80139540001
    CODGAN, James Raymond
    32 King Edwards Road
    SL5 8NY Ascot
    Berkshire
    Director
    32 King Edwards Road
    SL5 8NY Ascot
    Berkshire
    British19597140001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Director
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritish39034110001
    EVANS, Robert Owen
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    KAUFMAN, Gary
    10203 Castehill Court
    Ellicott
    Md 21042
    Usa
    Director
    10203 Castehill Court
    Ellicott
    Md 21042
    Usa
    UsaAmerican118968570001
    LOMAX, Christopher Morris David
    4 Greenwood Road
    WA13 0LA Lymm
    Cheshire
    Director
    4 Greenwood Road
    WA13 0LA Lymm
    Cheshire
    British32315330001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Director
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritish151547160001
    NORTON, John Laurence
    4 Waveney Close
    OX6 8GP Bicester
    Oxfordshire
    Director
    4 Waveney Close
    OX6 8GP Bicester
    Oxfordshire
    British34339250001
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Director
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Director
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Director
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritish76932830002

    ¿Tiene GREENBARR LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Credit agreement
    Creado el 18 jul 1991
    Entregado el 25 jul 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £53,003.16 due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Breve descripción
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 25 jul 1991Registro de una carga
    • 07 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement
    Creado el 13 mar 1991
    Entregado el 20 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £15949-24 due from the company under the terms of the agreement
    Breve descripción
    All right, title and interest under the insurance. See form 395 (ref 495).
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 20 mar 1991Registro de una carga
    • 07 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Credit agreement
    Creado el 10 may 1990
    Entregado el 22 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurances see form 395 (ref 136) for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 22 may 1990Registro de una carga
    • 07 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A registered charge
    Creado el 12 abr 1989
    Entregado el 27 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Breve descripción
    All its right, title & interest in & to all sums payable (including by way of refund (under the insurances. As from time time varied or extended & the benfit of all powers & remedies for cancelling and/or enforcing the same. (For full details see form M395-M50C).
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 27 abr 1989Registro de una carga
    • 07 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 mar 1987
    Entregado el 17 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 17 mar 1987Registro de una carga
    • 07 sept 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0