UCI DEVELOPMENTS LIMITED

UCI DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaUCI DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02090653
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Actividades de distribución de películas cinematográficas (59131) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UCI DEVELOPMENTS (UK) LIMITED02 may 198902 may 1989
    CIC12 ene 198912 ene 1989
    AMC DEVELOPMENTS (UK) LIMITED22 abr 198722 abr 1987
    GOLDENVISUAL LIMITED19 ene 198719 ene 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX

    2 páginasAD03

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX a 1 More London Place London SE1 2AF el 06 oct 2017

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX

    2 páginasAD02

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 sept 2017

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Kirsten Lawton como secretario el 18 may 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr John Brooks Rainer como director el 18 may 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kirsten Lawton como secretario el 18 may 2017

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Neil James Williams como director el 18 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Jonathan Way como director el 18 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Stephen Alker como director el 18 may 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Michael Donovan como director el 30 nov 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 22 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 oct 2015

    Estado de capital el 27 oct 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    7 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mrs Kirsten Lawton el 04 ago 2015

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RAINER, John Brooks
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Director
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United StatesAmerican230136900001
    FOX, Carol Collins
    Lee House
    90 Greay Bridgewater Street
    M1 5JW Manchester
    Secretario
    Lee House
    90 Greay Bridgewater Street
    M1 5JW Manchester
    British34028170003
    JAGANNATH, Vidya
    4 Caterham Avenue
    BL3 3RF Bolton
    Lancashire
    Secretario
    4 Caterham Avenue
    BL3 3RF Bolton
    Lancashire
    British104920640001
    LAWTON, Kirsten
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Secretario
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    British50045660003
    MCDONAGH, John James
    6 Redesmere Close
    Timperley
    WA15 7EE Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    6 Redesmere Close
    Timperley
    WA15 7EE Altrincham
    Cheshire
    British38769610001
    RIBBONS, Justin Charles
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    Secretario
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    British23745010013
    RICHARDS, James Timothy
    8a Marides Road
    Kensington
    W8 2LJ London
    Secretario
    8a Marides Road
    Kensington
    W8 2LJ London
    British30429210001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ALKER, Andrew Stephen
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritish120642230001
    DONOVAN, Paul Michael
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish154988050002
    GAVIN, Alexander Rupert
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Director
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    EnglandBritish16875680005
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Director
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124301460001
    HARRIS, Roger John
    Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    14
    Cheshire
    Director
    Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    14
    Cheshire
    United KingdomBritish129109390001
    HILDRED, Richard John
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    Director
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    United KingdomBritish112979700001
    HILDRED, Richard John
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    Director
    3 Beech Hill
    Mobberley
    WA16 7HT Cheshire
    United KingdomBritish112979700001
    RIBBONS, Justin Charles
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    Director
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    British23745010013
    RIBBONS, Justin Charles
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    Director
    Strayleaves
    8 Elm Rise
    SK10 4US Prestbury
    Cheshire
    British23745010013
    SINYOR, Joseph
    70 Sheldon Avenue
    N6 4ND London
    Director
    70 Sheldon Avenue
    N6 4ND London
    United KingdomBritish142528420002
    WAY, Mark Jonathan
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritish191239860001
    WILLIAMS, Neil James
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritish194329360001
    ESSENTIAL CINEMAS BV
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    Director corporativo
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    102479600001
    UNITED CINEMAS INTERNATIONAL MULTIPLEX BV
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    Director corporativo
    Amsteldijk 166
    1079 Lh
    Amsterdam
    Netherlands
    102479570001
    UNIVERSAL STUDIOS HOLDING III CORP
    800 Third Avenue
    New York
    Ny 10022
    Usa
    Director corporativo
    800 Third Avenue
    New York
    Ny 10022
    Usa
    98626030001
    UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV
    Hagedoornlaan 2
    PO BOX 37267
    FOREIGN Amsterdam
    1030 Ag
    Director corporativo
    Hagedoornlaan 2
    PO BOX 37267
    FOREIGN Amsterdam
    1030 Ag
    30239060004
    VIACOM INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV
    Naritaweg 207
    1043 Cb Amsterdam
    The Netherlands
    Director corporativo
    Naritaweg 207
    1043 Cb Amsterdam
    The Netherlands
    37696370007

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    United Cinemas International (Uk) Limited
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England
    06 abr 2016
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Liability Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies, Cardiff
    Número de registro1732125
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de un fideicomiso, y los fiduciarios de ese fideicomiso (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) poseen, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene UCI DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security registered in scotland on 28/2/91
    Creado el 28 feb 1991
    Entregado el 11 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee terms of a personal bond dated 4TH & 10TH october 1990
    Breve descripción
    All & whole the tenants part of lease relating to all & whole that area of ground extending 0.640 hectares in the clydesbank district of strathclyde region forming part of phase 111 of the clyde shopping centre, title no dmb 22832.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 11 mar 1991Registro de una carga
    • 12 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 dic 1989
    Entregado el 18 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Not exceeding £110,000,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of letter of credit, the overdraft facility and any relevant collateral dcoument (as defined)
    Breve descripción
    (See doc M395 ref M263L for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 18 dic 1989Registro de una carga
    • 26 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental loan agreement
    Creado el 07 nov 1989
    Entregado el 22 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £64,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/12/88 and this deed
    Breve descripción
    Floating charge over (see doc M551C for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 22 nov 1989Registro de una carga
    Supplemental loan agreement
    Creado el 14 sept 1989
    Entregado el 19 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement dated 12/12/88 and this deed
    Breve descripción
    Floating charge over (see 395-tc no. 213 for further details). Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 19 sept 1989Registro de una carga
    Supplemental loan agreement,
    Creado el 16 jun 1989
    Entregado el 03 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £48,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH december 1988 and this supplemental loan agreement
    Breve descripción
    Floating charge over all the undertaking, property assets and rights (see for 395 relative to this charge ref m 568C for full details).
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 03 jul 1989Registro de una carga
    Loan agreement
    Creado el 12 dic 1988
    Entregado el 28 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from amc entertainments (UK) limited and/or CIC multiplex cinemas B.V. to the chargee under the terms of the loan agreement
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all the undertaking, property assets and rights (please refer to doc M395 ref M364 for full details).
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 28 dic 1988Registro de una carga

    ¿Tiene UCI DEVELOPMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ago 2018Fecha de disolución
    13 sept 2017Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Profesional
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0