UCI DEVELOPMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | UCI DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02090653 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
- Actividades de distribución de películas cinematográficas (59131) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| UCI DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 02 may 1989 | 02 may 1989 |
| CIC | 12 ene 1989 | 12 ene 1989 |
| AMC DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 22 abr 1987 | 22 abr 1987 |
| GOLDENVISUAL LIMITED | 19 ene 1987 | 19 ene 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX a 1 More London Place London SE1 2AF el 06 oct 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kirsten Lawton como secretario el 18 may 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Brooks Rainer como director el 18 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kirsten Lawton como secretario el 18 may 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil James Williams como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Jonathan Way como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Stephen Alker como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Michael Donovan como director el 30 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mrs Kirsten Lawton el 04 ago 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER, John Brooks | Director | More London Place SE1 2AF London 1 | United States | American | 230136900001 | |||||
| FOX, Carol Collins | Secretario | Lee House 90 Greay Bridgewater Street M1 5JW Manchester | British | 34028170003 | ||||||
| JAGANNATH, Vidya | Secretario | 4 Caterham Avenue BL3 3RF Bolton Lancashire | British | 104920640001 | ||||||
| LAWTON, Kirsten | Secretario | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | British | 50045660003 | ||||||
| MCDONAGH, John James | Secretario | 6 Redesmere Close Timperley WA15 7EE Altrincham Cheshire | British | 38769610001 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Secretario | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RICHARDS, James Timothy | Secretario | 8a Marides Road Kensington W8 2LJ London | British | 30429210001 | ||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| ALKER, Andrew Stephen | Director | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 120642230001 | |||||
| DONOVAN, Paul Michael | Director | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | England | British | 154988050002 | |||||
| GAVIN, Alexander Rupert | Director | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | England | British | 16875680005 | |||||
| GOSLING, Steven Paul | Director | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 124301460001 | |||||
| HARRIS, Roger John | Director | Green Villa Park SK9 6EJ Wilmslow 14 Cheshire | United Kingdom | British | 129109390001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Director | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Director | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| RIBBONS, Justin Charles | Director | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Director | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| SINYOR, Joseph | Director | 70 Sheldon Avenue N6 4ND London | United Kingdom | British | 142528420002 | |||||
| WAY, Mark Jonathan | Director | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 191239860001 | |||||
| WILLIAMS, Neil James | Director | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 194329360001 | |||||
| ESSENTIAL CINEMAS BV | Director corporativo | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479600001 | |||||||
| UNITED CINEMAS INTERNATIONAL MULTIPLEX BV | Director corporativo | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479570001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS HOLDING III CORP | Director corporativo | 800 Third Avenue New York Ny 10022 Usa | 98626030001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV | Director corporativo | Hagedoornlaan 2 PO BOX 37267 FOREIGN Amsterdam 1030 Ag | 30239060004 | |||||||
| VIACOM INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV | Director corporativo | Naritaweg 207 1043 Cb Amsterdam The Netherlands | 37696370007 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Cinemas International (Uk) Limited | 06 abr 2016 | Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene UCI DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security registered in scotland on 28/2/91 | Creado el 28 feb 1991 Entregado el 11 mar 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee terms of a personal bond dated 4TH & 10TH october 1990 | |
Breve descripción All & whole the tenants part of lease relating to all & whole that area of ground extending 0.640 hectares in the clydesbank district of strathclyde region forming part of phase 111 of the clyde shopping centre, title no dmb 22832. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 dic 1989 Entregado el 18 dic 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Not exceeding £110,000,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of letter of credit, the overdraft facility and any relevant collateral dcoument (as defined) | |
Breve descripción (See doc M395 ref M263L for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental loan agreement | Creado el 07 nov 1989 Entregado el 22 nov 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £64,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Breve descripción Floating charge over (see doc M551C for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental loan agreement | Creado el 14 sept 1989 Entregado el 19 sept 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Breve descripción Floating charge over (see 395-tc no. 213 for further details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental loan agreement, | Creado el 16 jun 1989 Entregado el 03 jul 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £48,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH december 1988 and this supplemental loan agreement | |
Breve descripción Floating charge over all the undertaking, property assets and rights (see for 395 relative to this charge ref m 568C for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Loan agreement | Creado el 12 dic 1988 Entregado el 28 dic 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from amc entertainments (UK) limited and/or CIC multiplex cinemas B.V. to the chargee under the terms of the loan agreement | |
Breve descripción Fixed and floating charge over all the undertaking, property assets and rights (please refer to doc M395 ref M364 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene UCI DEVELOPMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0