SHIREC LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SHIREC LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02092754 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SHIREC LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SHIREC LIMITED?
| Dirección de la sede social | 100 Victoria Street SW1E 5JL London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHIREC LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NICHOLAS KING HOLDINGS LIMITED | 08 mar 1995 | 08 mar 1995 |
| CHARLES CHURCH HOLDINGS PLC | 17 mar 1989 | 17 mar 1989 |
| ALEXI CHURCH LIMITED | 23 feb 1987 | 23 feb 1987 |
| HADBRIDGE ESTATES LIMITED | 23 ene 1987 | 23 ene 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SHIREC LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHIREC LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Miller como director el 01 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Elizabeth Miles como director el 01 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Arnaouti como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Louise Miller como director el 01 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael Arnaouti el 16 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ls Director Limited el 10 ene 2017 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Land Securities Management Services Limited el 10 ene 2017 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ls Company Secretaries Limited el 10 ene 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL el 10 ene 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Land Securities Management Services Limited el 01 abr 2015 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Arnaouti como director el 01 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adrian Michael De Souza como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adrian Michael De Souza como secretario el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ls Company Secretaries Limited como secretario el 01 abr 2015 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SHIREC LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
| MILES, Elizabeth | Director | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 235498150001 | |||||||||
| LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director corporativo | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
| LS DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 | ||||||||||
| BAK, Paul Mario | Secretario | Greenacres August Lane Farley Green GU5 9DP Guildford Surrey | British | 67836240002 | ||||||||||
| DE SOUZA, Adrian Michael | Secretario | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | 160267340001 | |||||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Secretario | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| KING, Nicholas Geoffrey | Secretario | Grove Mill Windmill Hill HP7 0LZ Coleshill Bucks | British | 96115160001 | ||||||||||
| ARNAOUTI, Michael | Director | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||||||
| CHURCH, Susanna Bridgette | Director | Roundwood Micheldever SO21 2BA Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 3815910001 | |||||||||
| DE SOUZA, Adrian Michael | Director | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 158381390001 | |||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Director | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14674480002 | |||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Director | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14674480002 | |||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Director | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14674480002 | |||||||||
| FINLAY, Richard Anthony | Director | Flintstones St Leonards Hill SL4 4AT Windsor Berkshire | British | 3815920001 | ||||||||||
| FINLAY, Richard Anthony | Director | Flintstones St Leonards Hill SL4 4AT Windsor Berkshire | British | 3815920001 | ||||||||||
| KING, Jane Carol | Director | Piccadily House Marlow Road Lane End HP14 3NX High Wycombe Buckinghamshire | British | 75532110002 | ||||||||||
| KING, Nicholas Geoffrey | Director | Grove Mill Windmill Hill HP7 0LZ Coleshill Bucks | British | 96115160001 | ||||||||||
| MARSH, Richard William, Lord Marsh Of Mannington | Director | 25 Moreton Terrace SW1V 2NS London | British | 12558860001 | ||||||||||
| MERRY, Peter | Director | 82 Kings Ride Penn HP10 8BP High Wycombe Buckinghamshire | British | 100620530001 | ||||||||||
| MILLER, Louise | Director | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 199935770001 | |||||||||
| LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Director corporativo | 5 Strand WC2N 5AF London | 100069790001 | |||||||||||
| LS RETAIL DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Strand WC2N 5AF London 5 | 133821150001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SHIREC LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City & Central Shops Limited | 06 abr 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SHIREC LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creado el 14 nov 1990 Entregado el 29 nov 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the originial debenture and the original deed (as defined) | |
Breve descripción The property undertaking and assets mortgaged and charged by the original debenture and the original deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit agreement | Creado el 15 jun 1989 Entregado el 26 jun 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the counter indemnity dated 15.6.89 and this agreement | |
Breve descripción All the company's present and future right title & interest to or in any deposit account with county lease management limited (please see doc M395 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge over shares in charles church developments PLC | Creado el 21 mar 1989 Entregado el 04 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself, for the faciltiy agent and for the banks under or in connection with any security document. | |
Breve descripción I) by way of first fixed legal charge all and any title in the issued share capital of "developments" ii) all dividends, interest, accretions, rights etc (cont. See form 395 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 mar 1989 Entregado el 04 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself, for the facility agent and for the banks under or in connection with any security document | |
Breve descripción By way of first floating charge all of the. Undertaking and all property and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0