REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02101161 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
Dirección de la sede social | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
EVANS HALSHAW LIMITED | 08 mar 2005 | 08 mar 2005 |
REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED | 04 mar 2005 | 04 mar 2005 |
CADILLAC GB LIMITED | 09 sept 2004 | 09 sept 2004 |
REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED | 19 oct 1992 | 19 oct 1992 |
MERLIN (CAMBRIA) LIMITED | 27 mar 1987 | 27 mar 1987 |
RJT 58 LIMITED | 18 feb 1987 | 18 feb 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 28 may 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Philip Herbert como director el 30 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Simon Willis como director el 08 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Philip Herbert como director el 01 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Paul Holden como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Trevor Garry Finn como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como director el 01 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard James Maloney como secretario el 01 ene 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hilary Claire Sykes como secretario el 01 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Trevor Garry Finn el 18 oct 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALONEY, Richard James | Secretario | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | 222141180001 | |||||||||||
WILLIS, Mark Simon | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 229010610001 | ||||||||
PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director corporativo | 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House Nottinghamshire United Kingdom |
| 50880100004 | ||||||||||
HIBBERT, David Anthony | Secretario | Station Approach Duffield DE56 4HP Derby 5 Derbyshire | British | 128766470001 | ||||||||||
SYKES, Hilary Claire | Secretario | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | British | Company Secretary | 41559790001 | |||||||||
FINN, Trevor Garry | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 2652610013 | ||||||||
FORSYTH, David Robertson | Director | Scotland Cottage Melbourne DE73 1BH Derby | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 55127120002 | ||||||||
HERBERT, Mark Philip | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 123285980005 | ||||||||
HOLDEN, Timothy Paul | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | England | British | Chartered Accountant | 148034310003 | ||||||||
QUIGG, Kevin Barry | Director | 8 Derby Road Duffield DE56 4FL Derby | United Kingdom | British | Company Director | 97015090001 | ||||||||
SYKES, Hilary Claire | Director | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Secretary Director | 41559790001 | ||||||||
WHEELER, Ian | Director | Brookfield House Snelston DE6 2EP Ashbourne Derby Derbyshire | British | Chartered Accountant | 2685820010 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendragon Motor Group Limited | 06 abr 2016 | Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Creado el 13 may 2009 Entregado el 21 may 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0