SJPC 7 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSJPC 7 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02102279
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SJPC 7 LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SJPC 7 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    St. James'S Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SJPC 7 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ANGLO GROUP LIMITED23 feb 198723 feb 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SJPC 7 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SJPC 7 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SJPC 7 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Mrs Susan Meech como director el 12 dic 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Charles Woodd como director el 12 dic 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Charles Bellamy como director el 12 dic 2014

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de St James's Place Administration Limited como secretario el 07 oct 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de St. James's Place Corporate Secretary Limited como secretario el 07 oct 2014

    2 páginasAP04

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ago 2014

    Estado de capital el 28 ago 2014

    • Capital: GBP .1
    SH01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2013

    11 páginasAA

    legacy

    187 páginasPARENT_ACC

    Estado de capital el 18 jun 2014

    • Capital: GBP 0.10
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c and cap redemption reserve/ re dividend 14/05/2014
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2012

    11 páginasAA

    legacy

    164 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de SJPC 7 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ST. JAMES'S PLACE CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    Secretario corporativo
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro9131866
    192131860001
    CROFT, Andrew Martin
    Wythburn Court
    34 Seymour Place
    W1H 7NS London
    16
    Director
    Wythburn Court
    34 Seymour Place
    W1H 7NS London
    16
    EnglandBritish55940940004
    GLADMAN, Hugh John
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish41485310006
    MEECH, Susan Margaret
    Swinbrook
    OX18 4ED Burford
    The Forge
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Swinbrook
    OX18 4ED Burford
    The Forge
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish193649900001
    WOODD, Charles
    St Peter's Road
    GL7 1RG Cirencester
    18
    Gloucestershire
    England
    Director
    St Peter's Road
    GL7 1RG Cirencester
    18
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish193649250001
    LEATHERS, Michael Russell
    64 Sloane Street
    SW1X 9SH London
    Secretario
    64 Sloane Street
    SW1X 9SH London
    British68813320001
    ST JAMES'S PLACE ADMINISTRATION LIMITED
    Saint James S Place House
    Dollar Street
    GL7 2AQ Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario corporativo
    Saint James S Place House
    Dollar Street
    GL7 2AQ Cirencester
    Gloucestershire
    77087000002
    BAILEY, Charles Howard
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Director
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritish1992450001
    BELL, Ronald Edward, Mr.
    Glendevon 1a Woodpecker Close
    Ewshot
    GU10 5TH Farnham
    Surrey
    Director
    Glendevon 1a Woodpecker Close
    Ewshot
    GU10 5TH Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish119280590001
    BELLAMY, David Charles
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    Director
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish84428640001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Director
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    CRACKNELL, John David
    Mark House Aviary Road
    Pyrford
    GU22 8TH Woking
    Surrey
    Director
    Mark House Aviary Road
    Pyrford
    GU22 8TH Woking
    Surrey
    EnglandBritish637610001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    Director
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    British45468220001
    JOHNSTON, John Walford Philip
    58 Hampton Road
    TW11 0JX Teddington
    Middlesex
    Director
    58 Hampton Road
    TW11 0JX Teddington
    Middlesex
    British40292700001
    LANGFIELD, Andrea Valerie
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    Director
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    British52526910001
    MOULE, Martin David
    East Barn Limes Road
    Kemble
    GL7 6AD Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    East Barn Limes Road
    Kemble
    GL7 6AD Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish46052530001
    RICHARDS, Kenneth Samuel
    Boytons Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    Director
    Boytons Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish39995540001
    SANDERS, Stephen Robin
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    Director
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    British38839120001
    STAFFORD-DEITSCH, Andrew
    77 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Director
    77 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Us Citizen49540710001
    WOOD, David Neil
    Uplands 65 The Ridgeway
    TN10 4NL Tonbridge
    Kent
    Director
    Uplands 65 The Ridgeway
    TN10 4NL Tonbridge
    Kent
    British47106420001

    ¿Tiene SJPC 7 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge
    Creado el 05 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents.
    Breve descripción
    The common stock shares of sunnydale holdings limited with all divides distributies and interest.
    Personas con derecho
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 05 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents
    Breve descripción
    All stocks shares bonds and securities monies due therefrom see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 05 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the company with the trustee see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 05 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents
    Breve descripción
    All monies from time to time standing to the credit of the account with hambros bank limited see form 395 for details.
    Personas con derecho
    • Bangue Paribas for Itself and as Trustee for the Agent & Banks.
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 05 sept 1990
    Entregado el 19 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of even date and/or any security documents
    Breve descripción
    All book and other debts present and future see form 395 for schedule of documents.
    Personas con derecho
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transacciones
    • 19 sept 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 17 jul 1990
    Entregado el 18 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself the agent and the banks (as defined) under the terms of a loan agreement ad/or this assignment a d/or any other security document (as defined)
    Breve descripción
    All the rights,titles benefits and interest of the company all book debts revenues etc. (for more details see form 395 ref M8).
    Personas con derecho
    • Banque Paribas as Trustee for Itself, the Agent & the Banks (As Defined).
    Transacciones
    • 18 jul 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over securities
    Creado el 07 jun 1990
    Entregado el 19 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of the loan agreement dated 10/7/89 and/or this charge.
    Breve descripción
    First fixed charge over all stocks shares books ad securties including all dividends interest or other distribution (for more details see from 395 ref m 87).
    Personas con derecho
    • Banque Paribas as Agent & Trustee for Itself & the Banks (As Defined).
    Transacciones
    • 19 jun 1990Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 16 oct 1989
    Entregado el 30 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself or the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 10/7/89 and/or any other security document (as defined)
    Breve descripción
    A) all rights titles benefits & interests of the company whatsoever present & future whether proprietory contractural or otherwise under or arising out of or evidesced by the documents. B) all book & other debts revenues & claims present & future (including things in action) which may give rise to a debt, revenue or claim due or owing or which may become due or owing to the company under or by fiture of the assigned documents (see form 395 ref: M36 for full details).
    Personas con derecho
    • Banque Paribas
    Transacciones
    • 30 oct 1989Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Shares mortgage
    Creado el 11 jul 1989
    Entregado el 31 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the banks as defined) under the terms of a loan agreement of evendate.
    Breve descripción
    1,617,000 shares of common stock of sunningdale holdings limited & all dividends as distributions & interest (see form 395 ref M28 for full details).
    Personas con derecho
    • Banque Paribas
    Transacciones
    • 31 jul 1989Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over a deposit
    Creado el 10 jul 1989
    Entregado el 28 jul 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the banks (as defined) under the terms of a facility agreement of evendate.
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of on account of the company with the agent which is designated "cash collatereal account re anglo group".
    Personas con derecho
    • Banque Paribas
    Transacciones
    • 28 jul 1989Registro de una carga
    • 11 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0