INSTORE GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INSTORE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02105209 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INSTORE GROUP LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra INSTORE GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Trident Business Park Leeds Road HD2 1UA Huddersfield |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INSTORE GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PHANTOMTHUNDER LIMITED | 03 mar 1987 | 03 mar 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INSTORE GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INSTORE GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 08 ago 2017
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2016 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Hemant Patel como director el 27 nov 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian York como director el 27 nov 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Ian York como director el 26 mar 2015 | AP01 | |||||||||||
Cese del nombramiento de Roy George Ellis como director el 25 mar 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Abdul Aziz Tayub el 23 may 2013 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Roy George Ellis como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ebrahim Suleman como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INSTORE GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINSON, Martin Donald | Secretario | 1 Badger Gate Meltham HD9 5LB Holmfirth | British | 98796330005 | ||||||
| PATEL, Hemant | Director | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | England | British | 104124100001 | |||||
| TAYUB, Abdul Aziz | Director | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | England | British | 16280660001 | |||||
| HOLMES, Dennis | Secretario | 17 Wynford Rise LS16 6HX Leeds West Yorkshire | British | 2136680001 | ||||||
| KEMP, Helen Anne | Secretario | 5 Birch Mews Oaklands Manor Long Causeway Adel LS16 8NX Leeds West Yorkshire | British | 48922660002 | ||||||
| LETHAM, Ian Ritchie | Secretario | 45 Palin Wood Road Delph OL3 5UW Oldham Lancashire | British | 9252900001 | ||||||
| ROELOFSE, Hendrik | Secretario | 18 Woodlands Green HG2 8QD Harrogate North Yorkshire | South African | 40527920003 | ||||||
| SISSON, Hamish Paul | Secretario | 20 Park View Court 29 Street Lane LS8 1BS Leeds West Yorkshire | British | 43874820001 | ||||||
| BROWN, Gary James | Director | 3 Dewberry Fields Upholland WN8 0BQ Skelmersdale Lancashire | England | British | 125196870001 | |||||
| BURDON, Peter | Director | 40 Firs Road Edwalton NG12 4BX Nottingham | British | 70178470002 | ||||||
| CLARKE, Paul | Director | 74 Barons Close Kirby Muxloe LE9 2BW Leicester Leicestershire | British | 103719400001 | ||||||
| ELLIS, Robert Keith | Director | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | 45171010001 | |||||
| ELLIS, Roy George | Director | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | Wales | British | 161784490001 | |||||
| GRAY, Ian | Director | Flat 48 Langtons Wharf LS2 7EN Leeds Yorkshire | British | 50246030002 | ||||||
| HAUGHTON, Townsend Andrew | Director | Staddlestones 11 Oakdale Manor HG1 2NA Harrogate North Yorkshire | South Africa | 39356840002 | ||||||
| KERRISON, Michael Arthur | Director | 57 Welldon Crescent HA1 1QP Harrow Middlesex | British | 1452630001 | ||||||
| ROELOFSE, Hendrik | Director | 18 Woodlands Green HG2 8QD Harrogate North Yorkshire | South African | 40527920003 | ||||||
| SMITH, Martin Freeman | Director | 84 Pendle Gardens Culcheth WA3 4LU Warrington | British | 44140230002 | ||||||
| SULEMAN, Ebrahim | Director | 8 St Marys Avenue WF17 7PT Batley West Yorkshire | England | British | 52733940001 | |||||
| VISSER, Johan Jacobus | Director | 22 Mackenzie Gardens East Kilbride G74 4SA Glasgow Lanarkshire | South African | 51820380002 | ||||||
| YORK, Ian | Director | Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park United Kingdom | England | British | 197002910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de INSTORE GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instore Limited | 06 abr 2016 | Neptune Way, Leeds Road HD2 1UA Huddersfield Trident Business Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene INSTORE GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 28 mar 1996 Entregado el 15 abr 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined) to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the guarantee (as defined) | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 03 jun 1994 Entregado el 15 jun 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee and debenture | Creado el 10 ene 1992 Entregado el 24 ene 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of each or any of the finance documents (as defined) or otherwise | |
Breve descripción See form 395 ref M4C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 27 jun 1991 Entregado el 03 jul 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a charge dated 8-3-89 | |
Breve descripción First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company see form 395 (ref 32) for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 08 mar 1989 Entregado el 14 mar 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0