9524 TRADING

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresa9524 TRADING
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 02106632
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de 9524 TRADING?

    • (9261) /

    ¿Dónde se encuentra 9524 TRADING?

    Dirección de la sede social
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 9524 TRADING?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AMF BOWLING (TRADITIONAL)13 ago 201013 ago 2010
    AMF BOWLING21 abr 198721 abr 1987
    DIKAPPA (NUMBER 468) LIMITED05 mar 198705 mar 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de 9524 TRADING?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para 9524 TRADING?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cuenta final antes de la disolución

    19 páginasWU15

    Informe de progreso en una liquidación por el tribunal

    19 páginasWU07

    Aviso de destitución del liquidador por el tribunal

    6 páginasWU14

    Nombramiento de un liquidador

    7 páginasWU04

    Informe de progreso en una liquidación por el tribunal

    18 páginasWU07

    Presentación de insolvencia

    INSOLVENCY:Progress report ends 14/05/2016
    15 páginasLIQ MISC

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:liquidators annual progress report to 14/05/2015
    15 páginasLIQ MISC

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:annual progress report to 14/05/14
    15 páginasLIQ MISC

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:liquidator's progress report ;- 15/05/2012 - 14/05/2013
    14 páginasLIQ MISC

    Notificación de constitución del comité

    2 páginasF9.4

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    2 páginasF10.2

    Domicilio social registrado cambiado de * Star House Star Hill Rochester Kent ME1 1UX England* el 23 may 2012

    2 páginasAD01

    Orden del tribunal para liquidar

    COCOMP

    Nombramiento de un liquidador

    2 páginas4.31

    Orden del tribunal para liquidar

    2 páginasCOCOMP

    second-filing-of-form-with-form-type

    3 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 mar 2012Second filing TM01 for MR MEHDI FARAHMAND-AFSHAR

    Déclaration annuelle établie au 30 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 nov 2011

    Estado de capital el 02 nov 2011

    • Capital: GBP 280,335.27
    SH01

    Cese del nombramiento de Mehdi Farahmand-Afshar como director

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    14 mar 2012A second filing TM01 was registered on 14/03/2012

    Nombramiento de Mr Chris Neophytou como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Cook como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * Focus 31 North Wing Cleveland Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7EY England* el 02 nov 2010

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Peter Leslie Boughton como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de 9524 TRADING?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOUGHTON, Peter Leslie
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Director
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritishFinance Director120147560001
    NEOPHYTOU, Chris
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    Director
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House 1
    United KingdomBritishMarketing157364250001
    ANSCOMBE, Leslie Stephen
    45 Randall Road
    CV8 1JX Kenilworth
    Warwickshire
    Secretario
    45 Randall Road
    CV8 1JX Kenilworth
    Warwickshire
    British23996750001
    HARRIS, Paul Edward Woodstock
    4 Eaton Terrace
    SW1W 8EZ London
    Secretario
    4 Eaton Terrace
    SW1W 8EZ London
    BritishBanker85206160002
    PHELAN, Michael Ernest
    118 Beechfield
    EN11 9QL Hoddesdon
    Hertfordshire
    Secretario
    118 Beechfield
    EN11 9QL Hoddesdon
    Hertfordshire
    BritishAccountant61576430001
    ANSCOMBE, Leslie Stephen
    45 Randall Road
    CV8 1JX Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    45 Randall Road
    CV8 1JX Kenilworth
    Warwickshire
    BritishExecutive23996750001
    ARMSTRONG, Beverley Wilkes
    6319 Ridgeway Road
    Richmond
    23226 Virginia
    Usa
    Director
    6319 Ridgeway Road
    Richmond
    23226 Virginia
    Usa
    AmericanExecutive57687870001
    BARTA, Bernhard
    1190 Brookmeade Court
    IRISH Glen Allen
    Virginia Va 23059
    Usa
    Director
    1190 Brookmeade Court
    IRISH Glen Allen
    Virginia Va 23059
    Usa
    AustrianVp Sales75024230001
    CAESAR, Christopher Frank
    1903 Belgrave Road
    IRISH Richmond
    Virginia Va 23229
    Usa
    Director
    1903 Belgrave Road
    IRISH Richmond
    Virginia Va 23229
    Usa
    AmericanSenior Vp78735650001
    COLLIS, Katherine Lisa
    20 Sherwood Avenue
    Marshalswick
    AL4 9QL St Albans
    Hertfordshire
    Director
    20 Sherwood Avenue
    Marshalswick
    AL4 9QL St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant118106390001
    COOK, Richard John
    Wellpond Green
    SG11 1NN Standon
    Oaklands
    Herts
    Director
    Wellpond Green
    SG11 1NN Standon
    Oaklands
    Herts
    EnglandBritishProperty Director131384020001
    DIDLAKE JR, William Thomas
    8082 Fishtail Pond Court
    IRISH Mechanicsville
    Virginia Va 23111
    Usa
    Director
    8082 Fishtail Pond Court
    IRISH Mechanicsville
    Virginia Va 23111
    Usa
    AmericanAccountant85814870001
    FARAHMAND-AFSHAR, Mehdi
    Star Hill
    ME1 1UX Rochester
    Star House
    Kent
    England
    Director
    Star Hill
    ME1 1UX Rochester
    Star House
    Kent
    England
    EnglandBritishManaging Director155375280001
    FARINHOLT, Jonathan Mckenna
    2121 Park Ave
    IRISH Richmond
    Virginia 23225
    Usa
    Director
    2121 Park Ave
    IRISH Richmond
    Virginia 23225
    Usa
    AmericanDirector72080940001
    HADDON, Barbara
    17 The Abbey
    CV8 1LX Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    17 The Abbey
    CV8 1LX Kenilworth
    Warwickshire
    BritishExecutive30536320001
    HARE, Stephen Edward
    101 Lockgreen Place
    Richmond
    IRISH 23226
    Virginia
    Usa
    Director
    101 Lockgreen Place
    Richmond
    IRISH 23226
    Virginia
    Usa
    AmericanBusinessman68403530001
    HARRIS, Paul Edward Woodstock
    4 Eaton Terrace
    SW1W 8EZ London
    Director
    4 Eaton Terrace
    SW1W 8EZ London
    EnglandBritishBanker85206160002
    HARRIS, Peter Woodstock
    1 Park Lane
    HP2 4YL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    1 Park Lane
    HP2 4YL Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director65242660003
    HARRIS, Thomas Woodstock
    Grove House
    Grove
    LU7 0QU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    Grove House
    Grove
    LU7 0QU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director50142770005
    HUFFORD, Jonathan Gordon
    The Churchills
    Graemesdyke Road
    HP4 3YE Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    The Churchills
    Graemesdyke Road
    HP4 3YE Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector39210320002
    JAY, Ashby
    19 Napier Crescent
    Catisfield
    PO15 5BL Fareham
    Hampshire
    Director
    19 Napier Crescent
    Catisfield
    PO15 5BL Fareham
    Hampshire
    BritishSalesperson95941310001
    KEHOE, Laurence Patrick
    65 Highfield Road
    CM1 2NG Chelmsford
    Essex
    Director
    65 Highfield Road
    CM1 2NG Chelmsford
    Essex
    BritishManaging Director43744840005
    LEEMANS, Marc
    Kuntslaan 1
    L850 Boom
    Belgium 2850
    Director
    Kuntslaan 1
    L850 Boom
    Belgium 2850
    BritishCompany Director41171280001
    PETERSEN, Bent Enor
    18 Howards Thicket
    SL9 7NX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    18 Howards Thicket
    SL9 7NX Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    DanishExecutive30536330001
    PHELAN, Michael Ernest
    118 Beechfield
    EN11 9QL Hoddesdon
    Hertfordshire
    Director
    118 Beechfield
    EN11 9QL Hoddesdon
    Hertfordshire
    BritishAccountant61576430001
    ROOT, Mark Dennis
    16 The Coverts
    CM13 2JP Hutton
    Essex
    Director
    16 The Coverts
    CM13 2JP Hutton
    Essex
    EnglandBritishCommercial Director43744760002
    SATTERWHITE, Stephen Dale
    7283 Torbert Place
    IRISH Mechanicsville 23111
    Virginia
    Usa
    Director
    7283 Torbert Place
    IRISH Mechanicsville 23111
    Virginia
    Usa
    UsaAccountant89255750001
    SCOTT, Timothy Nicholas
    6032 Chestnut Hill Drive
    IRISH Glen Allen
    Virginia Va 23059
    Usa
    Director
    6032 Chestnut Hill Drive
    IRISH Glen Allen
    Virginia Va 23059
    Usa
    CanadianSenior Vice President85815040001
    SIMON, Lee Robert
    14 Badgers Hill
    Wentworth
    GU25 4SA Virginia Water
    Surrey
    Director
    14 Badgers Hill
    Wentworth
    GU25 4SA Virginia Water
    Surrey
    BritishExecutive51760300004
    SMITH, John Howard
    9111 Ashlar Place
    IRISH Mechanicsville 23111
    Virginia
    Usa
    Director
    9111 Ashlar Place
    IRISH Mechanicsville 23111
    Virginia
    Usa
    AmericanExec Vp89255780001
    SMITH, Roland Charles
    225 Brookchase Lane
    Richmond
    IRISH 23229
    Virginia
    Usa
    Director
    225 Brookchase Lane
    Richmond
    IRISH 23229
    Virginia
    Usa
    AmericanPresident/Ceo68403500002
    SPANGENBERG, Adolf, Vice President Emea
    Rue Jules Lejekne 19
    Brussels B-1050
    FOREIGN Belgium
    Director
    Rue Jules Lejekne 19
    Brussels B-1050
    FOREIGN Belgium
    GermanCeo Europe60993560001
    VIETH JR, George Walter
    3365 Green Hill Lane
    Louisville 40207
    Kentucky
    Usa
    Director
    3365 Green Hill Lane
    Louisville 40207
    Kentucky
    Usa
    AmericanCeo89255640001
    WERDEN, Merrell Clement
    13601 Sovereign Court
    Richmond
    FOREIGN Virginia 23233
    Usa
    Director
    13601 Sovereign Court
    Richmond
    FOREIGN Virginia 23233
    Usa
    AmericanDirector100164080001

    ¿Tiene 9524 TRADING alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of amendment
    Creado el 27 feb 2009
    Entregado el 18 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 18 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 sept 2004
    Entregado el 04 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H land on the north east side of finsley gate burnley t/n LA628309, l/h land to the east of currock road carlisle t/n's CU86799 and CU64712, l/h land being plot m lyme green business park brindley way london road macclesfield t/n CH348457 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit charge
    Creado el 06 dic 2000
    Entregado el 12 dic 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with or arising upon or in consequence of termination of a lease dated 19TH july 1990
    Breve descripción
    All monies from time to time standing to the credit of the company's account with national westminster bank PLC (account number 78539978).
    Personas con derecho
    • Forsakringsbolaget Spp, Omsesidigt
    Transacciones
    • 12 dic 2000Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene 9524 TRADING algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 oct 2018Conclusión de la liquidación
    03 feb 2012Fecha de la petición
    02 abr 2012Inicio de la liquidación
    07 abr 2019Fecha de disolución
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or Chatham Maritime
    1st Floor
    Prince Regent House
    ME4 4QZ Quayside
    Chatham Maritime Kent
    Profesional
    1st Floor
    Prince Regent House
    ME4 4QZ Quayside
    Chatham Maritime Kent
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Profesional
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    London
    Profesional
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    London
    Matthew David Smith
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Profesional
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0