GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED

GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02108766
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PICK INDEPENDENCE COMPUTER SYSTEMS LIMITED10 jun 198710 jun 1987
    TINTMUSTER LIMITED11 mar 198711 mar 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 feb 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 dic 2012

    Estado de capital el 18 dic 2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mrs Barbara Ann Firth el 11 dic 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2012

    6 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Paul David Gibson el 06 sept 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2011

    6 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Hilary Lowe como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Hilary Anne Lowe como secretario

    3 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Paul Gibson como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Ms Vinodka Murria el 01 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Paul David Gibson el 01 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Mark Harry Thompson como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Mr Paul David Gibson el 01 ene 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mrs Barbara Ann Firth el 01 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2010

    6 páginasAA

    Nombramiento de Barbara Ann Firth como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Fiona Timothy como director

    2 páginasTM01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2010 au 28 feb 2010

    2 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 13 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FIRTH, Barbara Ann
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Director
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Director
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Director
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    GIBSON, Paul David
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Secretario
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    British192439290001
    LOWE, Hilary Anne
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT11 3HQ Cobham
    Munro House
    Surrey
    British159478080001
    PYLE, Patricia Anne
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    Secretario
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    British22020080002
    DILLON, Pauline Anne
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    Director
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    British22020100001
    DILLON, Peter Gerald
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    Director
    18 Lower Landedmans
    Westhoughton
    BL5 2QL Bolton
    Lancashire
    British22020110001
    FRANKLIN, Christopher John
    7 Lytham Road
    Fulwood
    PR2 8JE Preston
    Lancashire
    Director
    7 Lytham Road
    Fulwood
    PR2 8JE Preston
    Lancashire
    British67032940001
    PYLE, Alexander Derek
    22 Severn Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TE Preston
    Lancashire
    Director
    22 Severn Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TE Preston
    Lancashire
    British22020120001
    PYLE, Michael Joseph
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    PR2 4XP Preston
    Lancashire
    Director
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    PR2 4XP Preston
    Lancashire
    British22020090002
    PYLE, Patricia Anne
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    Director
    10 Royal Avenue
    Fulwood
    Preston
    British22020080002
    ROLLINS, David
    17 Rookwood Avenue
    PR7 1RL Chorley
    Lancashire
    Director
    17 Rookwood Avenue
    PR7 1RL Chorley
    Lancashire
    British67032890001
    THOMPSON, Mark Harry
    The Bungalow
    Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Bungalow
    Forest Crescent
    KT21 1JU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish156095450001
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    Director
    Holly Cottage
    Kings Lane
    SL6 9AY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish161343370001

    ¿Tiene GOLDENHILL COMPUTER SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 mar 2007
    Entregado el 09 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 nov 2003
    Entregado el 25 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 02 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 feb 2001
    Entregado el 06 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 06 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 18 mar 1996
    Entregado el 22 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 22 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 sept 1990
    Entregado el 28 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1990Registro de una carga
    • 17 may 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0