I.B.T. LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | I.B.T. LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 02109154 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de I.B.T. LIMITED?
- Transporte de mercancías por carretera (49410) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra I.B.T. LIMITED?
Dirección de la sede social | C/O Mazars Llp 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de I.B.T. LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
I.B.C. TRANSPORT LIMITED | 11 mar 1987 | 11 mar 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de I.B.T. LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para I.B.T. LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 15 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby Stockton on Tees Cleveland TS17 6PT a C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT el 25 abr 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Victoria House Pearson Court Pearson Way Thornaby Stockton on Tees TS17 6PT | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2016 au 31 dic 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2015 | 11 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 71 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
Nombramiento de Mr Abraham Cornelis Paape como director el 10 mar 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Klaas Pieter Den Hartogh como director el 10 mar 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Loek Frans Jacob Kullberg como director el 10 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Scott Thomas Cunningham como director el 10 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Scott Thomas Cunningham como secretario el 10 mar 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Loek Frans Jacob Kullberg el 01 feb 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Scott Thomas Cunningham el 09 jun 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de I.B.T. LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN HARTOGH, Klaas Pieter | Director | Eastfield Road South Killingholme DN40 3DQ Immingham Eastfield Road South Humberside England | Netherlands | Dutch | Managing Director | 205933140001 | ||||
PAAPE, Abraham Cornelius | Director | Eastfield Road South Killingholme DN40 3DQ Immingham Eastfield Road South Humberside England | Netherlands | Dutch | Group Financial Director | 205995900001 | ||||
CUNNINGHAM, Scott Thomas | Secretario | Portland Park ML3 7JY Hamilton 41 Athol Bank Lanarkshire Scotland | British | Finance Director | 111223770001 | |||||
MAY, Brian Warner Lang | Secretario | PO BOX 165 Hedon Road HU9 1YY Hull | British | 9050410002 | ||||||
MOLENAAR, Roelof | Secretario | Rochussenstraat 45a FOREIGN Rotterdam 3015ec Netherlands | Dutch | Director | 70774490001 | |||||
ORVIS, Peter | Secretario | 9 Wauldby View Swanland HU14 3RE North Ferriby North Humberside | British | Accountant | 31145130001 | |||||
RICHARD, Timothy John | Secretario | Close Farm Ilmer HP27 9RD Princes Risborough Buckinghamshire | British | 85213810001 | ||||||
BONE, David Kenneth | Director | Foxcub Cottage Upper Street Billingford IP21 4HP Diss Norfolk | British | Director | 40294980003 | |||||
CUNNINGHAM, Scott Thomas | Director | Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby TS17 6PT Stockton On Tees Cleveland | Scotland | British | Director | 191625420001 | ||||
DARVILL, Alan Christopher | Director | 1 Ladygate HU17 8BH Beverley East Yorkshire | British | Company Director | 9689160001 | |||||
JEFFREY, David John | Director | 1 Putlowes Drive Fleet Marston HP18 0PX Ayesbury Buckinghamshire | England | British | Director | 92362550001 | ||||
JONES, Michael | Director | Shires The Paddock Stock CM4 9BG Ingatestones Essex | British | Chartered Accountant | 40295120001 | |||||
KULLBERG, Loek Frans Jacob | Director | Victoria House Pearson Court Pearson Way, Thornaby TS17 6PT Stockton On Tees Cleveland | Netherlands | Dutch | Company Director | 184998400002 | ||||
MARSHALL, John Neilson Adam | Director | Bell Hall Escrick YO19 6HL York | England | British | Director | 29783380003 | ||||
MARTIN, Victor William | Director | The Foxes Greenway Hutton Mount CM13 2NP Shenfield Essex | British | Director | 9689140001 | |||||
MAY, Brian Warner Lang | Director | PO BOX 165 Hedon Road HU9 1YY Hull | British | Company Director | 9050410002 | |||||
MOLENAAR, Roelof | Director | Rochussenstraat 45a FOREIGN Rotterdam 3015ec Netherlands | Dutch | Director | 70774490001 | |||||
NOEL, Michel | Director | Bergschenhoek Jf Kennedylaan 10 2661jh Netherlands | British | Finance Director | 129561360001 | |||||
PEARCH, Nicholas Keith | Director | Bradfield Manor Hullavington SN14 6EU Chippenham Wiltshire | British | Company Director | 69879060001 | |||||
RICHARDS, Timothy John | Director | Close End Farm Ilmer HP27 9RD Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British,Canadian | Company Director | 71050390002 | ||||
STATON, Joseph Howard | Director | 5 Beech Hill Road Swanland HU14 3QY North Ferriby East Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 41340700001 | ||||
VAN DER WARDT, Harald Christiaan | Director | Rotterdam 3055 Be Van Hoytemalaan 10 Netherlands | Netherlands | Dutch | Finance Director | 136444450001 | ||||
VAN WISSEN, Jacobus Cornelis Jozef | Director | Dromhille 5 Oud Beijerland 3261th Netherlands | Netherlands | Dutch | Managing Director | 134737410001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de I.B.T. LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Klaas Pieter Den Hartogh | 06 abr 2016 | Willingestraat 6 3087 An 3087AN Rotterdam 6 Netherlands | No |
Nacionalidad: Dutch País de residencia: Netherlands | |||
Naturaleza del control
|
¿Tiene I.B.T. LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 09 jun 2000 Entregado el 13 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Chattel mortgage | Creado el 27 sept 1999 Entregado el 05 oct 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 10 cpv, 25 litre pressure tanks, numbered IBTU125080 to IBTU125089. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Guarantee & debenture | Creado el 07 ene 1997 Entregado el 15 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 nov 1994 Entregado el 28 nov 1994 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene I.B.T. LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0