CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02110320
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RENTCO INTERNATIONAL LIMITED25 sept 198725 sept 1987
    VISORHEAD LIMITED13 mar 198713 mar 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 jun 2015
    Próximas cuentas vencen el31 mar 2016
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Segunda presentación para el nombramiento de Neil Smith como director

    6 páginasRP04AP01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF el 25 abr 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 31 mar 2016

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de T I P Europe Limited como director el 05 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Cakebread como director el 01 feb 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Neil Campbell Smith como director el 05 feb 2016

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    06 oct 2016Clarification A second filed AP01 was registered on 06/10/2016

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 nov 2015

    Estado de capital el 04 nov 2015

    • Capital: GBP .1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    16 páginasAA

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Subdivisión de acciones el 01 dic 2014

    8 páginasSH02

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    capital

    Resoluciones

    11,000,000 issued cumulative redeemable preference shares of £1 be sub-divided into 110,000,000 cumulative redeemable preference shares of £0.10 each 01/12/2014
    RES13

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 09 dic 2014

    • Capital: GBP 0.10
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account to nil 01/12/2014
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 dic 2014

    Estado de capital el 01 dic 2014

    • Capital: GBP 356,027,000
    SH01

    Misceláneos

    Section 519
    3 páginasMISC

    Renuncia del auditor

    3 páginasAUD

    ¿Quiénes son los directivos de CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro7038430
    146358090001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    Director
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    FranceUs Citizen183236480001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Secretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Secretario
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Secretario
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretario corporativo
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Director
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Director
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CAMFIELD, Ronald Frederick
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    Director
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    British81395090001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Director
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Director
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Director
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Director
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Director
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Director
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritish45623310001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Director
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Director
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    IRVING, Ian Richard
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    Director
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    EnglandBritish41228040001
    MATTHEWS, Terence
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    Director
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    British31419450002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Director
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Director
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Director
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    British4764800001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Director
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Director
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Director
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Director
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    THRASHER III, Barrie Holt
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    Director
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    American65472750001
    WILSON, Peter Samuel
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    Director
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    British59565220001
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    ¿Tiene CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 26 jul 1996
    Entregado el 30 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 30 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Account charge
    Creado el 15 mar 1994
    Entregado el 23 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an indemnity contained in a sale agreement dated 14TH december 1989 and this deed (as defined therein)
    Breve descripción
    All right title and interest of the company in and to both of the company's accounts no: 76653161 and 7943407. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC Barclays Mercantile Limited and Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 23 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 mar 1994
    Entregado el 21 mar 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a credit agreement dated 13TH february 1994 as amended on 15TH february 1994 and an agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and any other related security documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.("the Security Trustee")as Security Trustee for Itself and for the Secured Parties (As Defined in the Debenture)
    Transacciones
    • 21 mar 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 18 may 1987
    Entregado el 26 may 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent and trustee for the banks and/ohe overdraft bank as defined in the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Bank and Overdraft Bank
    Transacciones
    • 26 may 1987Registro de una carga
    • 10 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 18 may 1987
    Entregado el 26 may 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever agent and turstee for the banks and/or the overdroft bank as defired in the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Transacciones
    • 26 may 1987Registro de una carga
    • 10 dic 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 mar 2016Inicio de la liquidación
    16 abr 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0