GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02114602 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
- Actividades de telecomunicaciones inalámbricas (61200) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 41 Lothbury EC2R 7HF London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ANGLIA TELECOM CENTRES LIMITED | 13 oct 2003 | 13 oct 2003 |
| ANGLIA TELECOM CENTRES PUBLIC LIMITED COMPANY | 03 abr 1987 | 03 abr 1987 |
| COMETCROWN LIMITED | 24 mar 1987 | 24 mar 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 06 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 20 nov 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 06 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio de datos del secretario Stephanie Allen el 08 dic 2025 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Modification des détails de Giacom Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 dic 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Milton Gate 60 Chiswell Street London United Kingdom EC1Y 4AG United Kingdom a 41 Lothbury London EC2R 7HF el 08 dic 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Craig Barry Lovelace como director el 02 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Kenneth Boland como director el 30 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2024 | 21 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 73 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Nombramiento de Stephanie Allen como secretario el 25 nov 2024 | 6 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2023 | 21 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 73 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga 021146020022, creada el 28 sept 2023 | 90 páginas | MR01 | ||||||||||
Modification des détails de Digital Wholesale Solutions Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 jun 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed anglia telecom centres LIMITED\certificate issued on 30/06/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Digital Wholesale Solutions Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 may 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN, Stephanie | Secretario | Lothbury EC2R 7HF London 41 United Kingdom | 330340170001 | |||||||
| LOVELACE, Craig Barry, Mr. | Director | Lothbury EC2R 7HF London 41 United Kingdom | United Kingdom | British | 307898760001 | |||||
| MARKE, Nathan Richard | Director | Lothbury EC2R 7HF London 41 United Kingdom | United Kingdom | British | 194292450001 | |||||
| O'BRIEN, Terence John | Director | Lothbury EC2R 7HF London 41 United Kingdom | United Kingdom | British | 253414490001 | |||||
| RIGHTON, Timothy Paul | Director | Lothbury EC2R 7HF London 41 United Kingdom | United Kingdom | British | 253434790001 | |||||
| BAKER, Robert Earl | Secretario | 1 Smiths Place Grange Farm IP5 2YR Ipswich Suffolk | British | 78496930001 | ||||||
| BREWER, Ian David | Secretario | 160 George Street HP4 2EW Berkhamsted Hertfordshire | British | 83061460001 | ||||||
| DRIVER, Samantha Jayne | Secretario | 47 Western Drive Hanslope MK19 7LB Milton Keynes Buckinghamshire | British | 99655140001 | ||||||
| HAYES, Peter Andrew | Secretario | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Secretario | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | 149409780001 | |||||||
| NATHAN, Larry Graeme | Secretario | 45 West Hill Road SW18 1LE London | British | 49105010003 | ||||||
| PEARSON, Trevor John | Secretario | 2 Mere Gardens Rushmere St. Andrew IP4 5HU Ipswich Suffolk | British | 39647720002 | ||||||
| POLLARD, Graham John | Secretario | Gorse Farm Whyle Lane HR6 0RQ Pudleston Herefordshire | British | 79395160002 | ||||||
| RILEY, Anthony John | Secretario | Suite 1 Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | British | 89230160001 | ||||||
| SYNETT, Jacob Julian | Secretario | The Old Stables Pinnacle Place, Green Lane HA7 3AA Stanmore Middlesex | British | 78716770002 | ||||||
| VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis | Secretario | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 78459700001 | ||||||
| BAKER, Robert Earl | Director | 1 Smiths Place Grange Farm IP5 2YR Ipswich Suffolk | England | British | 78496930001 | |||||
| BALAAM, Martin Anthony | Director | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Director | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| BREWER, Ian David | Director | Croft Cottage Bellingdon HP5 2XW Chesham Buckinghamshire | England | British | 83061460003 | |||||
| CATTERICK, Simon | Director | 7a High Street CB10 1AT Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 87508490001 | |||||
| CHIRGWIN, Denis | Director | 363 Woodham Lane KT15 3PW Woodham Surrey | British | 76834030002 | ||||||
| COUGHLAN, Aidan Thomas | Director | Briarbank 42 Westerfield Road IP4 2UT Ipswich Suffolk | England | Irish | 40910650001 | |||||
| DUBENS, Peter Adam Daiches | Director | c/o C/O Oakley Capital Limited Cadogan Gate SW1X 0AS London 3 | Switzerland | British | 153016810001 | |||||
| GRIGGS, Gavin Peter | Director | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | 154536120001 | |||||
| HANNA, Michael | Director | 26 Turpins Avenue CO15 5HE Holland On Sea Essex | United Kingdom | British | 68319570001 | |||||
| JONES, Mark | Director | 92 Chipperfield Road WD4 9JD Kings Langley Hertfordshire | England | British | 58889440002 | |||||
| KIRKWOOD, Gareth Robert | Director | Suite 1 Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | 174056480001 | |||||
| LIVERTON, Michael William | Director | 142 Long Road Lawford CO11 2HS Manningtree Essex | British | 65649380001 | ||||||
| MCGINN, David Raymond | Director | 2 Starkey Close Cheshunt EN7 6WE Waltham Cross Hertfordshire | British | 66045000002 | ||||||
| MCGLENNON, David Lewis | Director | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | United Kingdom | British | 181536600001 | |||||
| MULLER, Neil Keith | Director | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | 252490400001 | |||||
| PEARSON, Trevor John | Director | 2 Mere Gardens Rushmere St. Andrew IP4 5HU Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | 39647720002 | |||||
| PERKS, Timothy Howard | Director | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 100207880001 | |||||
| RILEY, Anthony John | Director | Suite 1 Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire | England | British | 89230160001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GIACOM (DISTRIBUTION) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacom Limited | 12 mar 2021 | Lothbury EC2R 7HF London 41 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Digital Wholesale Solutions Holdings Limited | 12 jul 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Daisy Intermediate Holdings Limited | 06 abr 2016 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0