BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 02116502 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| B.M.B.S. LAND DEVELOPMENT LIMITED | 30 mar 1987 | 30 mar 1987 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 23 sept 2020 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lloyds Secretaries Limited como secretario el 08 sept 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Johan Robin Charles Von Schmidt Auf Altenstadt el 21 ene 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Tower House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Tower House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Trinity Road Halifax West Yorkshire HX1 2RG a 1 More London Place London SE1 2AF el 10 oct 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Janet Turner como director el 15 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Johan Robin Charles Von Schmidt Auf Altenstadt como director el 15 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Janet Turner el 10 ene 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Stuart Dolman como director el 09 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Janet Turner como director el 09 nov 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 may 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT, Johan Robin Charles | Director | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 254275760001 | |||||||||
| COLLINS, Jacqueline Lesley | Secretario | Village Farm Eaton Upon Tern TF9 2BX Market Drayton Shropshire | British | 23846370008 | ||||||||||
| DICKIE, Charles George | Secretario | The Malthouse Folley Road Ackleton WV6 7JL Wolverhampton West Midlands | British | 7608010001 | ||||||||||
| GITTINS, Paul | Secretario | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | 164928150001 | |||||||||||
| LOCKWOOD, Angela | Secretario | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | British | 115797910001 | ||||||||||
| MAYER, Sally | Secretario | 48 Prospect Street Shibden Heights HX3 6LG Halifax | British | 75435950002 | ||||||||||
| MCPHERSON, Donald James | Secretario | 17 Cross Bank BD23 6AH Skipton North Yorkshire | British | 40519810003 | ||||||||||
| SOBO, Femi | Secretario | 5 Carr Bridge View Cookridge LS16 7BR Leeds | British | 55778050002 | ||||||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Secretario | 2 Coverdale Garth Collingham LS22 5LR Wetherby West Yorkshire | British | 44542620002 | ||||||||||
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| BEDDOWS, Peter Richard | Director | Austcliffe House Farm Austcliffe Road Cookley DY10 3UR Kidderminster Worcestershire | England | British | 14142380001 | |||||||||
| BRIGHT, Stephen Michael | Director | The Ferns Histons Hill Codsall WV8 2EY Wolverhampton West Midlands | England | British | 7817150001 | |||||||||
| DOLMAN, Mark Stuart | Director | PO BOX 112 Canons Way BS99 7LB Bristol Canons House England England | United Kingdom | British | 169566090001 | |||||||||
| JACKSON, Michael, Doctor | Director | Ivy Cottage Strawmoor Lane WV8 2HY Oaken Wolverhampton | British | 89250950001 | ||||||||||
| JOYCE, John Henry | Director | 14 Lothians Road Tettenhall WV6 9PR Wolverhampton West Midlands | British | 12058740001 | ||||||||||
| KERR, Ian David | Director | 22 Ivetsey Close Wheaton Aston ST19 9QR Stafford Staffordshire | British | 57441480002 | ||||||||||
| POPE, Darren Scott | Director | Chief Office Barnett Way, Gloucester, Gl4 7rl Cheltenham & Gloucester Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 133746080001 | |||||||||
| ROGERS, John William | Director | Iddesleigh House 52 Main Road Middlezoy TA7 0NN Bridgwater Somerset | British | 17713980002 | ||||||||||
| STEWART, Ian Gordon | Director | Lovell Park Road LS1 1NS Leeds Lovell Park United Kingdom | United Kingdom | British | 82245010005 | |||||||||
| THOMAS, William Guy | Director | Beech House Wolverhampton Road TF11 9HA Shifnal Salop | England | British | 54968670001 | |||||||||
| TURNER, Janet | Director | 5th Floor 25 Gresham Street EC2V 7HM London Lloyds Banking Group United Kingdom | United Kingdom | British | 239996920001 | |||||||||
| WATKINS, Daniel John | Director | Gretton Mill Gilberries Lane Cardington SY6 7HZ Church Stretton Shropshire | United Kingdom | British | 50866500002 | |||||||||
| WHITE, Paul Matthew | Director | 21 Prince Street BS1 4PH Bristol Lloyds Banking Group United Kingdom | England | British | 62104870002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of Scotland Plc | 06 abr 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 28 feb 1990 Entregado el 08 mar 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with a facility letter dated 22.8.89 or any further facility letters that may be issued by the chargee including further advances. | |
Breve descripción 83-91 (odd numbers inclusive) orphanage road, erdington, birmingham, west midlands title no's wk 105623, wm 257876, wm 889415 and wk 65460. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 ago 1989 Entregado el 09 ago 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 23/7/89 or any further facility letters | |
Breve descripción Land at chiphouse road and pear tree lane, kingswood avon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene BIRMINGHAM MIDSHIRES LAND DEVELOPMENT LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0