METO UK LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMETO UK LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02118737
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de METO UK LTD?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra METO UK LTD?

    Dirección de la sede social
    Leat House
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de METO UK LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CHECKPOINT SYSTEMS (UK) LIMITED 15 sept 199315 sept 1993
    I D SYSTEMS LIMITED21 abr 198721 abr 1987
    GALESOVER LIMITED02 abr 198702 abr 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de METO UK LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para METO UK LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC08

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 16 mar 2018

    2 páginasPSC09

    Nombramiento de Mr Kamel Mormech como director el 20 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Erik Albert Laurentius Cardinaal como director el 20 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jamie Robinson como director el 19 jun 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Scott Andrew Mitchell-Harris como director el 19 jun 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Erik Albert Laurentius Cardinaal como director el 06 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Andrew Bewell como director el 11 ene 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de Per Harald Levin como director el 01 jun 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Scott Andrew Mitchell-Harris como director el 01 jun 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark Anthony Beckram como director el 01 jun 2016

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 mar 2016

    Estado de capital el 24 mar 2016

    • Capital: GBP 29,844,015
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mr Neil Andrew Bewell como director el 26 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Jeffrey Oliver Richard como director el 20 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 mar 2015

    Estado de capital el 12 mar 2015

    • Capital: GBP 29,844,015
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    13 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jeffrey Oliver Richard como director el 31 ago 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anne Broudic como director el 31 ago 2014

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de METO UK LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BECKRAM, Mark Anthony
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant119588680001
    MORMECH, Kamel
    Pioneer Way
    WF10 5QU Castleford
    Unit 3
    England
    Director
    Pioneer Way
    WF10 5QU Castleford
    Unit 3
    England
    EnglandBritishCompany Director238246230001
    ROBINSON, Jamie
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director236333930001
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Secretario
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    BritishCompany Secretary38963210007
    ANGEL, William
    Laan Van De Marel 14
    FOREIGN 7823ca Emmen
    The Netherlands
    Secretario
    Laan Van De Marel 14
    FOREIGN 7823ca Emmen
    The Netherlands
    British11750710001
    BRINK, Albert
    Van Der Ouder Meulenlaan 11a
    FOREIGN 2243 Cr Wassenaar
    Holland
    Secretario
    Van Der Ouder Meulenlaan 11a
    FOREIGN 2243 Cr Wassenaar
    Holland
    British27930320002
    JUDD, Claire
    13 Wellesley
    CM19 5QX Harlow
    Essex
    Secretario
    13 Wellesley
    CM19 5QX Harlow
    Essex
    BritishAccountant34760860001
    ADAMS, Raymond Paul George
    24 Walden Road
    AL8 7PF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    24 Walden Road
    AL8 7PF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishAccountant11018940001
    AUSTIN, Neil D
    45 Sturbridge Lane
    19380 West Chester
    Pennsylvania
    Usa
    Director
    45 Sturbridge Lane
    19380 West Chester
    Pennsylvania
    Usa
    Us AmericanCompany Director46243710001
    BEWELL, Neil Andrew
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Controller106120360001
    BROUDIC, Anne
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    SpainFrenchAssociate General Counsel177692480001
    CARDINAAL, Erik Albert Laurentius
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    NetherlandsDutchCompany Director224173010001
    DE NOOD, Cornelis Simon Adriaan
    Borsboom Toussaint Straat 15
    FOREIGN 384222 Harderwijk
    The Netherlands
    Director
    Borsboom Toussaint Straat 15
    FOREIGN 384222 Harderwijk
    The Netherlands
    DutchCompany Executive11750700001
    DIAMOND, Graham Mcdonald
    Karlsruher Ring 11
    Stutensee
    76297
    Germany
    Director
    Karlsruher Ring 11
    Stutensee
    76297
    Germany
    BritishCompany Director61983830001
    HENDRIKS, Karel
    Rietzangerweg 151
    FOREIGN 1111 Vk Diemen
    Holland
    Director
    Rietzangerweg 151
    FOREIGN 1111 Vk Diemen
    Holland
    DutchFinancial Director27930330001
    HIGGS, Raymond Ronald
    Inglenook
    Hook End Road, Hook End
    CM15 0NR Brentwood
    Essex
    Director
    Inglenook
    Hook End Road, Hook End
    CM15 0NR Brentwood
    Essex
    BritishManaging Director66869920001
    LESSE, Pontus
    75 Rue Du Cornet
    1040 Brussels
    Belgium
    Director
    75 Rue Du Cornet
    1040 Brussels
    Belgium
    SwedishVice-President56422290002
    LEVIN, Per Harald
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    SpainSwedishVice President General Manager77149690002
    MATTHEWS, Neil Michael Philip
    13 Bellever Hill
    GU15 2HB Camberley
    Surrey
    Director
    13 Bellever Hill
    GU15 2HB Camberley
    Surrey
    United KingdomUnited KingdomGeneral Manager86145850001
    MIDANI, Stephen George
    Daxani House 45a Broadfern Road
    Knowle
    B93 9DE Solihull
    West Midlands
    Director
    Daxani House 45a Broadfern Road
    Knowle
    B93 9DE Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director64315980001
    MITCHELL-HARRIS, Scott Andrew
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    EnglandBritishEngineer210841140001
    NUTTALL, David Alan
    The Wolery
    Earlstone Common
    RG20 9HN Burghclere
    Berkshire
    Director
    The Wolery
    Earlstone Common
    RG20 9HN Burghclere
    Berkshire
    BritishManaging Director106534870001
    RAYNER, Keith Mackay
    1 Carolina Place
    RG40 4PQ Finchampstead
    Berkshire
    Director
    1 Carolina Place
    RG40 4PQ Finchampstead
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director29153220002
    REINHOLD, Jeffrey Alan
    2029 Delancey Place
    19103 Philadelphia
    Pennsylvania
    Usa
    Director
    2029 Delancey Place
    19103 Philadelphia
    Pennsylvania
    Usa
    AmericanFinancial Officer64538540001
    RICHARD, Jeffrey Oliver
    101 Wolf Drive
    Thorofare
    Checkpoint Systems
    New Jersey 08086
    Usa
    Director
    101 Wolf Drive
    Thorofare
    Checkpoint Systems
    New Jersey 08086
    Usa
    UsaUs CitizenEvp & Chief Financial Officer190868520001
    SELFRIDGE, Steven
    2 Buxley Court
    NJ 08081 Erial
    Usa
    Director
    2 Buxley Court
    NJ 08081 Erial
    Usa
    AmericanExecutive44987470001
    VAN ZILE, John R
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    Director
    Overbridge Square
    RG14 5UX Newbury
    Leat House
    Berkshire
    United StatesAmericanAttorney Business Person Senio96418630004

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para METO UK LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    16 mar 2018La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.
    02 mar 201716 mar 2018La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado.

    ¿Tiene METO UK LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 feb 1993
    Entregado el 03 mar 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (For full details see C.H. microfiche). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Internationale Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transacciones
    • 03 mar 1993Registro de un cargo (395)
    Account assignment
    Creado el 16 feb 1993
    Entregado el 03 mar 1993
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due from the company and/or id systems internationale bv to the chargee on any account whatsoever under the terms of a block discounting agreement of even date and/or this account assignment
    Breve descripción
    All monies credited to and standing to the credit of the account of the company with barclays bank PLC no. 8049687 together with all interest accrued thereon together with the debt represented thereby, the said account and all other assets of the company charged pursuant to the terms of the account assignment.
    Personas con derecho
    • Internationale Nederlanden Lease (UK) Limited
    Transacciones
    • 03 mar 1993Registro de un cargo (395)
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Creado el 30 jul 1992
    Entregado el 08 ago 1992
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £29,858.40 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Breve descripción
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance see doc for details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1992Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0