AIM HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAIM HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 02120855
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AIM HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra AIM HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AIM HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AIM LIMITED08 may 198708 may 1987
    EASYCROWN LIMITED08 abr 198708 abr 1987

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AIM HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para AIM HOLDINGS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AIM HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    GAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 oct 2013

    Estado de capital el 02 oct 2013

    • Capital: GBP 730,012
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 feb 2013

    12 páginasAA

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Nombramiento de Denise Williams como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kerry Crompton como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Barbara Ann Firth como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Preedy como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul David Gibson como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como secretario

    2 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* el 25 mar 2013

    2 páginasAD01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 28 feb 2013

    3 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2012

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Richard Ian Preedy el 15 ago 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 14 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Richard Ian Preedy el 16 ago 2012

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Richard Ian Preedy como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Ms Kerry Jane Crompton el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de AIM HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952300001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    BOOTH, Michael David
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    Secretario
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    British88167500001
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Secretario
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    British113317640001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    ANDERSON, James Douglas
    4 Stirling Road
    EH5 3HY Edinburgh
    Director
    4 Stirling Road
    EH5 3HY Edinburgh
    United KingdomBritish15707300001
    BAGAN, Helen
    Flat 4 Spencer Court
    Spencer Place
    N1 2AX London
    Director
    Flat 4 Spencer Court
    Spencer Place
    N1 2AX London
    United KingdomBritish102014660001
    BEARPARK, Richard Mosely
    Broadfield
    16 Clifford Manor Road
    GU4 8AG Guildford
    Surrey
    Director
    Broadfield
    16 Clifford Manor Road
    GU4 8AG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish121373650001
    BOOTH, Michael David
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    Director
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    EnglandBritish88167500001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    DAVIS, John Terence
    Greenacres 9 Beverley Road
    Market Weighton
    YO4 3JN York
    North Yorkshire
    Director
    Greenacres 9 Beverley Road
    Market Weighton
    YO4 3JN York
    North Yorkshire
    British44635630002
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Director
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish113317640001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Director
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    GARTON, Peter Stuart
    11 Church Street
    Anlaby
    HU10 7DG Hull
    North Humberside
    Director
    11 Church Street
    Anlaby
    HU10 7DG Hull
    North Humberside
    British36207450001
    HEWITT, David Dennis
    18 Melton Road
    North Ferriby
    HU14 3ET Hull
    East Yorkshire
    Director
    18 Melton Road
    North Ferriby
    HU14 3ET Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritish76597830001
    HUNT, Peter Charles
    14 The Spinney
    Swanland
    HU14 3RD North Ferriby
    North Humberside
    Director
    14 The Spinney
    Swanland
    HU14 3RD North Ferriby
    North Humberside
    British22690310001
    JEFFREY, John Ewan
    6 Kilmany Road
    Wormit
    DD6 8PF Newport On Tay
    Fife
    Director
    6 Kilmany Road
    Wormit
    DD6 8PF Newport On Tay
    Fife
    British23890370001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Director
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Director
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    TAYLOR, Keith Edwin
    Church View Ivy Lane
    Hedon
    HU12 8BL Hull
    North Humberside
    Director
    Church View Ivy Lane
    Hedon
    HU12 8BL Hull
    North Humberside
    United KingdomBritish16866320001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Director
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330003
    WILDE, John Henry
    5 Wilkesley Cottages
    Wilkesley
    SY13 4BA Whitchurch
    Director
    5 Wilkesley Cottages
    Wilkesley
    SY13 4BA Whitchurch
    British36207460002

    ¿Tiene AIM HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 oct 2007
    Entregado el 15 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transacciones
    • 15 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creado el 19 oct 2006
    Entregado el 02 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Keyman assignation
    Creado el 04 jul 1996
    Entregado el 17 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Policy no. 3967240 dated 29TH may 1996 with scottish equitable for the sum of £200,000 on the life of stephen taylor parker together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignation of life policy
    Creado el 29 sept 1994
    Entregado el 07 oct 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Policy number 3741771 dated 21.3.94 for the sum of £200,000 and all bonuses and benefits and all rights title and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 oct 1994Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 abr 1994
    Entregado el 17 may 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in terms of the £350,000 10% redeemable secured loan stock 1994 of the company created on 21ST december 1993
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Melville Street Investments PLC Limitedas Agent for Itself and British Linen Securities
    Transacciones
    • 17 may 1994Registro de un cargo (395)
    • 30 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of offset.
    Creado el 20 jun 1990
    Entregado el 02 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from aim LTD aim commercial systems LTD, aim supplies and print LTD,aim professional systems LTD training services LTD aim retail systems LTD aim communications services LTD aim law data LTD aim finance LTD to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All sums of the company on any account held by the bank.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jul 1990Registro de una carga
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 ago 1987
    Entregado el 27 ago 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Govenor & Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 ago 1987Registro de una carga
    • 05 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene AIM HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ene 2014Inicio de la liquidación
    05 nov 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0